STRIPEMICRO LIMITED

STRIPEMICRO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTRIPEMICRO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04733405
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STRIPEMICRO LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova STRIPEMICRO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Dfw Associates
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di STRIPEMICRO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STRIPEMICRO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2019

    24 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2018

    15 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 giu 2017

    14 pagineLIQ03

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 16 giu 2016

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da Chester Railway Station 1st Floor West Wing Offices Station Road Chester Cheshire CH1 3NT a Dfw Associates 29 Park Square West Leeds West Yorkshire LS1 2PQ in data 13 giu 2016

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mag 2016

    Stato del capitale al 25 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2015

    Stato del capitale al 06 mag 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2014

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2014

    Stato del capitale al 17 giu 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Nomina di Theo Michell come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Lovelady come segretario

    2 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * North House, 17 North John Street, Liverpool Merseyside L2 5EA* in data 26 feb 2014

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Andrew Lovelady come amministratore

    2 pagineTM01

    Nomina di Louise Gail Emery come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Helen Silvano come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Michael Owen come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2013

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di STRIPEMICRO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EMERY, Louise Gail
    1st Floor West Wing Offices
    Station Road
    CH1 3NT Chester
    Chester Railway Station
    Cheshire
    Segretario
    1st Floor West Wing Offices
    Station Road
    CH1 3NT Chester
    Chester Railway Station
    Cheshire
    British185454520001
    EMERY, Josephine Angela, Dr
    Hibbert Court Birtles Hall
    Birtles Lane
    SK10 4RU Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    Hibbert Court Birtles Hall
    Birtles Lane
    SK10 4RU Macclesfield
    Cheshire
    EnglandBritish103455000001
    MICHELL, Theodore William Henry
    James Street
    W1U 1EZ London
    46
    United Kingdom
    Amministratore
    James Street
    W1U 1EZ London
    46
    United Kingdom
    United KingdomBritish125430720001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Segretario
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    British41693730006
    SILVANO, Helen
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    Segretario
    The Stables 1b Grange Park
    Maghull
    L31 3DP Liverpool
    Merseyside
    British55343270002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    LAMONT, Neil John Duncan
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    20 Barker Street
    CW5 5TE Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish90161100001
    LOVELADY, Andrew Robert
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    Amministratore
    50 Tollemache Road
    CH43 8SZ Prenton
    Merseyside
    United KingdomBritish41693730006
    OWEN, Michael Barry
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    Amministratore
    Barrow Lane
    Great Barrow
    CH3 7HW Chester
    The Old Rectory
    Cheshire
    EnglandBritish69716360003
    WADSWORTH, David Ian
    Chelwood House
    Malpas Road
    SY14 7HH Tilston
    Cheshire
    Amministratore
    Chelwood House
    Malpas Road
    SY14 7HH Tilston
    Cheshire
    United KingdomBritish47890600002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    STRIPEMICRO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 22 giu 2009
    Consegnato il 25 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Parkside 3 herons way chester business park chester. T/no.CH579538 and all buildings, structures, fixtures (including trade fixtures) & fixed plant & machinery & equipment from time to time thereon all right title & interest to, & in any proceeds of any present and future insurances of the property. Any present & future goodwill of the business (if any) & by way of floating charge, all moveable plant, machinery, implements, utensils, furniture & equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge on deposit
    Creato il 22 giu 2009
    Consegnato il 25 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of acount number 25812830 (sort code 301474) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 25 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 26 nov 2008
    Consegnato il 28 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at wrexham road farm chester t/no CH524695 and land at parkside 3 chester t/no CH579538; rental income; floating charge the undertaking and all other property assets and rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ethel Austin Properties Holdings Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 20 dic 2007
    Consegnato il 09 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/Hold property at wrexham rd,chester. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 09 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 04 ott 2007
    Consegnato il 10 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 1 hilliards court chester business park chester t/no CH346813 and f/h land and buildings k/a 1B hilliards court chester business park chester and parking spaces t/no CH384901. And all buildings structures fixtures (including trade fixtures) and fixed plant machinery and equipment from time to time thereon all right title and interest to and in any proceeds of any present or future insurances of the property any present and future goodwill of the business (if any) and by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2007
    Consegnato il 10 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    STRIPEMICRO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 giu 2016Inizio della liquidazione
    24 gen 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David Frederick Wilson
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds
    Praticante
    29 Park Square West
    LS1 2PQ Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0