FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFRASERS VINCENT SQUARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04734907
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    FAIRPOINT PROPERTIES (VINCENT SQUARE) LIMITED15 apr 200315 apr 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2015

    Stato del capitale al 23 giu 2015

    • Capitale: GBP 2
    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 giu 2013

    SH01

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 15 apr 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Seng Khoon Ng il 15 apr 2011

    1 pagineCH03

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    19 pagineMG01

    Nomina di Valsec Company Secretarial Services Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Valad Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NG, Seng Khoon
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    Segretario
    81 Cromwell Road
    London
    SW7 5BW
    British90211410001
    CHIA, Khong Shoong
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    Amministratore
    Alexandra Road
    # 21-00 Alexandra Point
    438
    Singapore 119958
    SingaporeSingaporean141112510002
    LEAR, Simon John Patrick
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    United KingdomBritish138750860001
    QUEK, Stanley Swee Han, Dr
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    Amministratore
    Cromwell Road
    SW7 5BW London
    81
    SingaporeSingaporean123800250001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Segretario
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    British812680001
    MCS FORMATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Segretario
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69736830002
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Segretario
    Melville Street
    EH3 7NS Edinburgh
    4a
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Segretario
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7307485
    154204150001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    BALCHIN, Mark Nicholas
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    Amministratore
    6 Fleming Close
    GU14 8BT Farnborough
    Hampshire
    UkBritish812680001
    CHEONG, Anthony Fook Seng
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Amministratore
    263 River Valley Road
    No 13-20 Aspen Hegihts
    FOREIGN Singapore
    238309
    Singapore
    Malaysian77121980001
    DODWELL, John Christopher
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    Amministratore
    1 Stable House Hope Wharf
    St Mary Church Street Rotherhithe
    SE16 4JX London
    United KingdomBritish95741610002
    HENG, Jeffrey Wah Yong
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Amministratore
    60 Chuan Garden
    FOREIGN Singapore
    558570
    Singapore
    Singaporean70088270001
    LEAR, Simon John Patrick
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    Amministratore
    2 Orchard Road
    TW1 1LY St Margarets
    Middlesex
    United KingdomBritish107485520001
    LIM, Ee Seng
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    Amministratore
    56 Lorong Melayu
    Sinapore
    416942
    SingaporeanSingaporean123920850001
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    NG, Seng Khoon
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    Amministratore
    101 Coldershaw Road
    W13 9DU London
    EnglandBritish90211410001
    VAN REYK, Philip
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    Amministratore
    Cherry Tree House
    Chequers Lane
    RG27 0NT Eversley
    Hampshire
    EnglandBritish76943220003
    MCS INCORPORATIONS LIMITED
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    Amministratore
    235 Old Marylebone Road
    NW1 5QT London
    69737020001

    FRASERS VINCENT SQUARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 23 dic 2010
    Consegnato il 31 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company each obligor investor or the investors' guarantor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 31 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment
    Creato il 19 lug 2006
    Consegnato il 22 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The entire right title and interest in and to the specific contracts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property situate at 63-69 (odd) rochester row and 68 vincent square london SW1 title number NGL785625. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 mag 2003
    Consegnato il 10 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0