D M C PROPERTIES LTD

D M C PROPERTIES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàD M C PROPERTIES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04754925
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di D M C PROPERTIES LTD?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova D M C PROPERTIES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Mercer & Hole Trinity Court
    Church Street
    WD3 1RT Rickmansworth
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di D M C PROPERTIES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 set 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per D M C PROPERTIES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 28 set 2021 al 27 set 2021

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Batchworth House Batchworth Place Church Street Rickmansworth Herts WD3 1JE a C/O Mercer & Hole Trinity Court Church Street Rickmansworth WD3 1RT in data 31 mag 2022

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 28 set 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2019

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 set 2018

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047549250009 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047549250008 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio di micro-entità redatto al 28 set 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 apr 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di D M C PROPERTIES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCNICHOLAS, Sean Bernard
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    Segretario
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    Irish90061670004
    DOYLE, Patrick Gerard
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    Amministratore
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    EnglandIrish86621900005
    MCNICHOLAS, Sean Bernard
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    Amministratore
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    United KingdomIrish90061670004
    CURRIE, Sean Andrew
    82a Creffield Road
    Acton
    W3 9PX London
    Segretario
    82a Creffield Road
    Acton
    W3 9PX London
    British86622010001
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Segretario nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    CURRIE, Sean Andrew
    82a Creffield Road
    Acton
    W3 9PX London
    Amministratore
    82a Creffield Road
    Acton
    W3 9PX London
    British86622010001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Amministratore delegato nominato
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Chi sono le persone con controllo significativo di D M C PROPERTIES LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Patrick Gerrard Doyle
    W12 9 AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    06 apr 2016
    W12 9 AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: Irish
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Sean Bernard Mcnicholas
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    06 apr 2016
    W12 9AU London
    157 Askew Road
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: Irish
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    D M C PROPERTIES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 dic 2013
    Consegnato il 13 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Oak wharf green lane london W7 2PF as registered under title number MX332458. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 13 dic 2013
    Consegnato il 13 dic 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All estates and other interests in freehold leasehold and or unregistered immovalbe property. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Close Brothers Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 16 lug 2007
    Consegnato il 19 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 209 cavendish road balham london LN16785. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 19 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal mortgage
    Creato il 05 apr 2007
    Consegnato il 21 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H oak wharf green lane hanwell london t/no mx 332458. by way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 05 apr 2007
    Consegnato il 21 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 gen 2004
    Consegnato il 23 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property known as 1 rosemount road acton ealing t/n NGL378239 and all buildings & erections thereon. All plant, machinery, fixtures, fittings & other equipment and effects. All options, agreements, the benefit of all policies of insurance and all warranties together with all monies payable. All rents, licence fees, service charges and other monies arising out of all leases, tenancy agreements or licences. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 gen 2004
    Consegnato il 23 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property known as 1 rosemount road acton ealing t/n NGL378239. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Leopold Joseph & Sons Limited
    Transazioni
    • 23 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 25 giu 2003
    Consegnato il 28 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 28 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 gen 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0