SPORTS HOLDINGS LIMITED

SPORTS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPORTS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04765076
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Suite 26 4 Montpelier Street
    SW7 1EE London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 1952 LIMITED15 mag 200315 mag 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Indirizzo della sede legale modificato da 21 Mount Grove Edgware Middlesex HA8 9SY United Kingdom a Suite 26 4 Montpelier Street London SW7 1EE in data 07 dic 2016

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Philipp Grothe come amministratore in data 01 dic 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 ago 2016

    Stato del capitale al 19 ago 2016

    • Capitale: GBP 2,246,428.6
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 21 Alan Silverstein & Co 21 Mount Grove Edgware Middlesex HA8 9SY England a 21 Mount Grove Edgware HA8 9SY

    1 pagineAD02

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Q3, the Square Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TW England a 21 Alan Silverstein & Co 21 Mount Grove Edgware Middlesex HA8 9SY

    1 pagineAD02

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Eighth Floor 6 New Street Square London EC4A 3AQ a 21 Mount Grove Edgware Middlesex HA8 9SY in data 04 feb 2016

    1 pagineAD01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Lower Mill Kingston Road Epsom Surrey KT17 2AE United Kingdom a Q3, the Square Randalls Way Leatherhead Surrey KT22 7TW

    1 pagineAD02

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 15 mag 2015

    18 pagineRP04

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 giu 2015

    Stato del capitale al 29 giu 2015

    • Capitale: GBP 2,246,428.6
    SH01
    Note
    DataNota
    30 lug 2015Clarification A Second filed AR01 is registered on 30/07/2015

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Philippe Huber come amministratore in data 04 dic 2014

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2013 al 30 dic 2013

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Jonathan Paul Hill come amministratore in data 14 lug 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2014

    Stato del capitale al 20 mag 2014

    • Capitale: GBP 2,246,428.6
    SH01

    Cessazione della carica di Lisa Anderson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jerome Anderson come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeffrey Weston come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SPORTS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HONEYMAN, Craig
    14 Foxglove Close
    DL5 4PF Woodham
    County Durham
    Segretario
    14 Foxglove Close
    DL5 4PF Woodham
    County Durham
    British107972620001
    LEVY, Rupert James
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    Segretario
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    BritishDirector57681630002
    PETERS, Stuart Anthony
    29 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    Segretario
    29 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    British75175640001
    RADEKE, Christian
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Segretario
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    British149574100001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    ANDERSON, Jerome
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Amministratore
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    United KingdomBritishDirector48116600001
    ANDERSON, Lisa
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Amministratore
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    United KingdomBritishCompany Director29336530002
    ANDERSON, Maurice
    27 Freston Garden
    EN4 9LX Cockfosters
    Hertfordshire
    Amministratore
    27 Freston Garden
    EN4 9LX Cockfosters
    Hertfordshire
    BritishCompany Director98810740001
    GROTHE, Philipp
    Mount Grove
    HA8 9SY Edgware
    21
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Mount Grove
    HA8 9SY Edgware
    21
    Middlesex
    United Kingdom
    United KingdomGermanDirector93423640003
    HILL, Jonathan Paul
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Unit 207
    Amministratore
    The Chambers
    Chelsea Harbour
    SW10 0XF London
    Unit 207
    EnglandBritishChief Operating Officer151681080002
    HUBER, Philippe
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Amministratore
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    EnglandSwissConsultant136530960001
    LEVY, Rupert James
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    Amministratore
    25 Muswell Avenue
    N10 2EB London
    BritishDirector57681630002
    LUPER, John Michael
    11 Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    11 Sandmoor Drive
    LS17 7DF Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector9264860001
    OGUN, Adrian
    16 Kensington Avenue
    CR7 8BY Thornton Heath
    Surrey
    Amministratore
    16 Kensington Avenue
    CR7 8BY Thornton Heath
    Surrey
    BritishDirector73251690003
    PETERS, Stuart Anthony
    29 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    Amministratore
    29 Howberry Road
    HA8 6SS Edgware
    Middlesex
    United KingdomBritishAdministrator75175640001
    RADEKE, Christian
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Amministratore
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    GermanController132358580001
    SILVERSTONE, Peter
    Flat 5, Southside Quarter
    38 Burns Road, Battersea
    SW11 5GY London
    Amministratore
    Flat 5, Southside Quarter
    38 Burns Road, Battersea
    SW11 5GY London
    United KingdomBritishDirector153527610001
    WESTON, Jeffrey
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    Amministratore
    6 New Street Square
    EC4A 3AQ London
    Eighth Floor
    United KingdomBritishFootball Agent88926310001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    SPORTS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Floating charge
    Creato il 18 dic 2007
    Consegnato il 04 gen 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge all the company's undertaking property assets and rights whatsoever and wheresoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Guinness Flight Vct PLC Proven Growth and Income Vct PLC Proven Vct PLC and the Global Rightsfund Ii LP (The Lenders)
    Transazioni
    • 04 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Memorandum of deposit of stocks and shares
    Creato il 26 gen 2004
    Consegnato il 28 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The declares that the stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for or nominees of the bank and specified in the schedule to the memorandum. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Memorandum of deposit of stocks and shares and other marketable securities
    Creato il 11 set 2003
    Consegnato il 13 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The stocks shares bonds debentures or other securities deposited with or transferred to the bank or trustees for the nominees of the bank and specified in the schedule to the memorandum. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2003
    Consegnato il 25 giu 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 25 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0