SYNERGY GRACECHURCH LIMITED

SYNERGY GRACECHURCH LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSYNERGY GRACECHURCH LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04768708
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3201) LIMITED18 mag 200318 mag 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 19 set 2019

    7 pagineLIQ03

    Nomina di Willem De Jager come amministratore in data 18 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Banks come amministratore in data 18 set 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da One Coleman Street London EC2R 5AA a 30 Finsbury Square London EC2P 2YU in data 19 ott 2018

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 20 set 2018

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    23 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    24 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2016

    Stato del capitale al 20 mag 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 047687080008, creata il 26 nov 2015

    32 pagineMR01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 26 nov 2015

    • Capitale: GBP 52,030,019
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    resolution

    Risoluzione di capitalizzazione o emissione di azioni bonus

    Capitalisation of 52029898 ordinary shares @ £1 each 26/11/2015
    RES14

    Memorandum e Statuto

    9 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 26 nov 2015

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 18 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2015

    Stato del capitale al 18 mag 2015

    • Capitale: GBP 121
    SH01

    Chi sono gli amministratori di SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LEGAL & GENERAL CO SEC LIMITED
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    Segretario
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4548651
    147653290001
    AITCHISON, Gordon Clark
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritishChartered Surveyor146947440001
    DE JAGER, Willem
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomDutchFinance Business Partner262768260001
    WHELAN, Michael
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    Segretario
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    164963340001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    JC SECRETARIES LIMITED
    76 King Street
    M2 4NH Manchester
    Lancashire
    Uk
    Segretario
    76 King Street
    M2 4NH Manchester
    Lancashire
    Uk
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04600034
    86092550001
    ALLARD, Tyrone James
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    The Spires
    BT18 9DY Holywood
    3
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandIrishAccountant2343150005
    BANKS, Andrew
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    Amministratore
    Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    30
    United KingdomBritishAccountant80999260001
    BARRETT, John
    Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    IRISH Dublin 14
    31
    Dublin 14
    Ireland
    Amministratore
    Whitebeam Avenue
    Clonskeagh
    IRISH Dublin 14
    31
    Dublin 14
    Ireland
    IrelandIrishAccountant89358820003
    BRETT, Alexander James
    Leslie Avenue
    Dalkey
    Avalon
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Leslie Avenue
    Dalkey
    Avalon
    County Dublin
    Ireland
    Rep. Of IrelandIrishDirector165351850001
    KANERICK, Robert Philip
    201 Goldhurst Terrace
    NW6 3ER London
    Amministratore
    201 Goldhurst Terrace
    NW6 3ER London
    EnglandBritishCompany Director64145800001
    MAXWELL, David Cleland
    78 Buckingham Gate
    SW1E 6PE London
    Buckingham Court
    Uk
    Amministratore
    78 Buckingham Gate
    SW1E 6PE London
    Buckingham Court
    Uk
    United KingdomBritishDirector91230860002
    RYAN, Damien Michael
    Saintbury House
    Saintbury Avenue, Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    Amministratore
    Saintbury House
    Saintbury Avenue, Killiney Hill Road
    Killiney
    County Dublin
    Ireland
    IrelandIrishDirector89077170002
    TAGLIAFERRI, Mark Lee
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    Amministratore
    Flat 2
    105 Cadogan Gardens
    SW3 2RF London
    EnglandBritishDirector106792270001
    TRAUB, Stephen Eric Cameron
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    Amministratore
    Norwood Drive
    BT4 2EA Belfast
    22
    County Antrim
    United Kingdom
    Northern IrelandBritishAccountant143642110001
    WHELAN, Michael
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    Amministratore
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    IrelandIrishEngineer164245970001
    WHITTON, Robert David
    5 Raphael Avenue
    Gidea Park
    RM1 4EP Romford
    Essex
    Amministratore
    5 Raphael Avenue
    Gidea Park
    RM1 4EP Romford
    Essex
    BritishDirector69537740002
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SYNERGY GRACECHURCH LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Coleman Street
    EC2R 5AA London
    One
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleUnited Kingdom (England)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione00166055
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SYNERGY GRACECHURCH LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 nov 2015
    Consegnato il 03 dic 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Legal and General Assurance Society Limited
    Transazioni
    • 03 dic 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Supplemental debenture
    Creato il 18 apr 2005
    Consegnato il 27 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit account (number 43824206 sort code 40-52-41). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (London Branch)
    Transazioni
    • 27 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 08 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    200A ordinary shares of £1 each in the capital of the company. Any dividend interest or monies paid or payable in relation to any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (Secured Party)
    Transazioni
    • 08 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 08 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Additional property being the f/h land and buildings at 70 gracechurch street 168 fenchurch street and 22-23 lime street london EC4 t/n ngl 748318. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (Acting Through Its London Branch) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 08 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsh Nordbank Ag (Acting Through Its London Branch) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 28 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors and the borrower to the agent, the security trustee the lenders and the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A supplemental debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 28 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings at 70 gracechurch street 168 fenchurch street and 22-23 lime street london EC3 t/no NGL748318.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SYNERGY GRACECHURCH LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 set 2018Inizio della liquidazione
    22 apr 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Sean Kenneth Croston
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0