AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED

AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04778942
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    99 Gresham Street
    EC2V 7NG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AVERY WEIGH-TRONIX UK (HOLDINGS) LIMITED28 mag 200328 mag 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 giu 2014

    Stato del capitale al 10 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Ola Tricia Aramita Barreto-Morley come amministratore in data 31 mar 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Giles Matthew Hudson il 21 mag 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 nov 2011 al 31 dic 2011

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 nov 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Philip Matthew Deakin il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Edward Ufland il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per S & J Registrars Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Ola Tricia Aramita Barreto-Morley il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Giles Hudson il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2009

    12 pagineAA

    Cessazione della carica di Gavin Udall come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    1 pagine288a

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 nov 2008

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione01740543
    132600000001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish161583790003
    UFLAND, Edward
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    United KingdomBritish87558180001
    FOGARTY, Robert Joseph
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    British17437720002
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    BOWE, Gerald Grant
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    Amministratore
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    American86912720003
    CASTLE, David Rayner
    47 Frederick Road
    Edgbaston
    B15 1HN Birmingham
    Amministratore
    47 Frederick Road
    Edgbaston
    B15 1HN Birmingham
    American86859030001
    CRAMER, Carl, Mr.
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    Amministratore
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    United KingdomBritish92710960001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Amministratore
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    39090660001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    Amministratore
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    41864110001

    AVERY WEIGH-TRONIX UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • European Capital Financial Services Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge, material real property, other real property, other assets being book debts, investments, uncalled capital, intellectual property by way of first floating charge its undertaking and all its assets both present and future. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0