OAK FOUNDATION

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOAK FOUNDATION
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited'
    Numero di società 04784264
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OAK FOUNDATION?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari
    • Attività dei call center (82200) / Attività amministrative e di supporto
    • Strutture residenziali di assistenza per anziani e disabili (87300) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova OAK FOUNDATION?

    Indirizzo della sede legale
    80 Cheapside
    EC2V 6EE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OAK FOUNDATION?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per OAK FOUNDATION?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Soddisfazione dell'onere 047842640004 in pieno

    1 pagineMR04

    L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa

    1 pagineDISS16(SOAS)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Rita Elaine Mathews come amministratore in data 30 gen 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Patrick Laurence Egan come amministratore in data 13 nov 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Rimozione di una società come proprietario sociale

    2 pagineHC02

    Modifica dei dettagli di Luminus Group Limited come persona con controllo significativo il 10 giu 2019

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Patrick Laurence Egan come amministratore in data 15 nov 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Cowans come amministratore in data 15 nov 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    37 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Reverend Kevin Robin Burdett il 25 set 2018

    2 pagineCH01

    Nomina di Mrs Cecilia Mary Tredget come amministratore in data 16 ago 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Lynette Lackey come amministratore in data 16 ago 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 16 ago 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Luminus Group Limited come persona con controllo significativo il 19 apr 2018

    2 paginePSC05

    Risoluzioni

    Resolutions
    28 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Indirizzo della sede legale modificato da Brook House Ouse Walk Huntingdon Cambs, PE29 3QW a 80 Cheapside London EC2V 6EE in data 19 apr 2018

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Finney il 26 mar 2018

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Nigel Finney come amministratore in data 26 mar 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 26 mar 2018

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di OAK FOUNDATION?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Christopher Paul
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Segretario
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    245057170001
    BURDETT, Kevin Robin, Reverend
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishReverned219612400002
    FINNEY, David Nigel
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Brook House
    England
    Amministratore
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Brook House
    England
    EnglandBritishManaging Director245096730002
    FORREST, Michael Leslie
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishDirector Of Studies In An Independent School190860110001
    LACKEY, Lynette
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritishDirector191938950001
    TREDGET, Cecilia Mary
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishDirector183600040001
    ABRAHAM, Chan Raj
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Segretario
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    160337410001
    ABRAHAM, Chan Raj
    31 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    Segretario
    31 West End
    Brampton
    PE28 4SD Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishChief Executive66633310001
    DAVIDSON, Nairn
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Segretario
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    236201270001
    HALDANE, Ruth Kathleen
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Segretario
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    British91188830001
    ABRAHAM, Chan Raj
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomBritishChief Executive66633310001
    ADEY, Ladey
    78 Ambleside
    Bedgrove
    HP21 9TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    78 Ambleside
    Bedgrove
    HP21 9TX Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishDirector122158120001
    ATTWOOLL, Shirley Admonita
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishTrainee Solicitor114406860002
    ATTWOOLL, Shirley Admonita
    106 Hartford Road
    PE29 1XG Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    106 Hartford Road
    PE29 1XG Huntingdon
    Cambridgeshire
    EnglandBritishTrainee Solicitor114406860002
    BANERJEE, Madhabi
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomBritishRetired88471200001
    BOSTON, Janet Elizabeth
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishN/A180717660001
    BRENCH, Rosalyn Margaret
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishChartered Accountant94856690002
    COWANS, David
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishDirector108543490005
    CUBITT, Robert Ian, Dr
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandEnglishDoctor157785720002
    DDAMULIRA, Elizabeth Nalumooza
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandUgandanTenancy And Income Manager204656090001
    EGAN, Patrick Laurence
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    United KingdomBritishCompany Director45432980001
    ELSWORTH, Lee
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishAccountant193011140001
    GODLEY, Maurice Peter
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomBritishCounty Councillor138890310001
    HARTY, David
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishRetired134003730001
    HARTY, David
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishRetired134003730001
    HOMEWOOD, Paul Adrian
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomBritishCarpenter111718750001
    HUNTER, William
    31 Park Road
    Buckden
    PE19 5SL St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    31 Park Road
    Buckden
    PE19 5SL St Neots
    Cambridgeshire
    BritishInterim Manager96074400001
    JOHNSON, Timothy Phillip
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    EnglandBritishChartered Accountant68808980001
    KALYAPU, Abraham
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomZambianYouth Pastor121831630001
    MATHEWS, Rita Elaine
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishDistrict Councillor/Retired Accountant64355750002
    MUIR, Ian Ross
    4a Orchard Way
    Ramsey
    PE26 1JF Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    4a Orchard Way
    Ramsey
    PE26 1JF Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishRetired15102800002
    OWEN, David Michael
    11 Middlemiss View
    Godmanchester
    PE29 2YW Huntingdon
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    11 Middlemiss View
    Godmanchester
    PE29 2YW Huntingdon
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritishInsurance Broker90034160001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    Amministratore
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    EnglandBritishDirector46176700002
    SETCHELL, Jack
    9 Queensway
    PE19 1EN St. Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    9 Queensway
    PE19 1EN St. Neots
    Cambridgeshire
    BritishRetired Police Officer64505090002
    STEVENS, Thomas Henry
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    Amministratore
    Brook House
    Ouse Walk
    PE29 3QW Huntingdon
    Cambs,
    United KingdomBritishSelf Employed119367410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di OAK FOUNDATION?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    06 apr 2016
    Cheapside
    EC2V 6EE London
    80
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Guarantee Without Share Capital
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleEnglish Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04782653
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OAK FOUNDATION ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 ott 2015
    Consegnato il 27 ott 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Langley court langley st ives cambridgeshire.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Luminus Finance Limited
    Transazioni
    • 27 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charitable subsidiary fixed charge
    Creato il 23 ott 2009
    Consegnato il 29 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    31 hill rise st ives CB223978 6 prins avenue wisbech CB140832 20 wintringham road st neots CB250817 please see form for further charges. All buildings and fixtures proceeds of sale covenants moneys paid see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Luminus Finance Limited
    Transazioni
    • 29 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charitable subsidiary fixed charge
    Creato il 04 mar 2008
    Consegnato il 20 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties being 10 bell lane, alconbury t/no CB235645, 8 bell lane, alconbury t/no CB235645, 1 crown gardens, alconbury t/no CB235645. For details of further property charged please refer to form 395. together with all buildings and fixtures, all plant and machinery, all contracts, licences and all oak foundations rights. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Luminus Finance Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A form of charitable subsidiary fixed charge
    Creato il 07 apr 2004
    Consegnato il 20 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all the property being flats 1 to 29 ashtonhouse laburnum avenue incorretly referred to in the property register and title plan as aston house t/n CB254793, 1 to 4 (incl) baron court and 47 to 61 (odd) duloe brook st neots t/n CB253586, 5 to 8 (incl) baron court and 63 to 69 (odd) duloe brook st neots t/n CB253585 by way of first fixed charge all plant and machineryhsbc bank PLC. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Luminus Group Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0