OAK FOUNDATION
Panoramica
Nome della società | OAK FOUNDATION |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
Numero di società | 04784264 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OAK FOUNDATION?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari
- Attività dei call center (82200) / Attività amministrative e di supporto
- Strutture residenziali di assistenza per anziani e disabili (87300) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova OAK FOUNDATION?
Indirizzo della sede legale | 80 Cheapside EC2V 6EE London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di OAK FOUNDATION?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per OAK FOUNDATION?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 047842640004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
L'azione di cancellazione obbligatoria è stata sospesa | 1 pagine | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio | 1 pagine | GAZ1 | ||||||||||
Cessazione della carica di Rita Elaine Mathews come amministratore in data 30 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Patrick Laurence Egan come amministratore in data 13 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Rimozione di una società come proprietario sociale | 2 pagine | HC02 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Luminus Group Limited come persona con controllo significativo il 10 giu 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Nomina di Mr Patrick Laurence Egan come amministratore in data 15 nov 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Cowans come amministratore in data 15 nov 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 37 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Reverend Kevin Robin Burdett il 25 set 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Cecilia Mary Tredget come amministratore in data 16 ago 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Lynette Lackey come amministratore in data 16 ago 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 16 ago 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 lug 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Luminus Group Limited come persona con controllo significativo il 19 apr 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 28 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Brook House Ouse Walk Huntingdon Cambs, PE29 3QW a 80 Cheapside London EC2V 6EE in data 19 apr 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Finney il 26 mar 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr Nigel Finney come amministratore in data 26 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Christopher Robin Leslie Phillips come amministratore in data 26 mar 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di OAK FOUNDATION?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Christopher Paul | Segretario | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | 245057170001 | |||||||
BURDETT, Kevin Robin, Reverend | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | Reverned | 219612400002 | ||||
FINNEY, David Nigel | Amministratore | Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Brook House England | England | British | Managing Director | 245096730002 | ||||
FORREST, Michael Leslie | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | Director Of Studies In An Independent School | 190860110001 | ||||
LACKEY, Lynette | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | United Kingdom | British | Director | 191938950001 | ||||
TREDGET, Cecilia Mary | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | Director | 183600040001 | ||||
ABRAHAM, Chan Raj | Segretario | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | 160337410001 | |||||||
ABRAHAM, Chan Raj | Segretario | 31 West End Brampton PE28 4SD Huntingdon Cambridgeshire | British | Chief Executive | 66633310001 | |||||
DAVIDSON, Nairn | Segretario | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | 236201270001 | |||||||
HALDANE, Ruth Kathleen | Segretario | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | British | 91188830001 | ||||||
ABRAHAM, Chan Raj | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | British | Chief Executive | 66633310001 | ||||
ADEY, Ladey | Amministratore | 78 Ambleside Bedgrove HP21 9TX Aylesbury Buckinghamshire | British | Director | 122158120001 | |||||
ATTWOOLL, Shirley Admonita | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Trainee Solicitor | 114406860002 | ||||
ATTWOOLL, Shirley Admonita | Amministratore | 106 Hartford Road PE29 1XG Huntingdon Cambridgeshire | England | British | Trainee Solicitor | 114406860002 | ||||
BANERJEE, Madhabi | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | British | Retired | 88471200001 | ||||
BOSTON, Janet Elizabeth | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | N/A | 180717660001 | ||||
BRENCH, Rosalyn Margaret | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Chartered Accountant | 94856690002 | ||||
COWANS, David | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | Director | 108543490005 | ||||
CUBITT, Robert Ian, Dr | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | English | Doctor | 157785720002 | ||||
DDAMULIRA, Elizabeth Nalumooza | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | Ugandan | Tenancy And Income Manager | 204656090001 | ||||
EGAN, Patrick Laurence | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | United Kingdom | British | Company Director | 45432980001 | ||||
ELSWORTH, Lee | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Accountant | 193011140001 | ||||
GODLEY, Maurice Peter | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | British | County Councillor | 138890310001 | ||||
HARTY, David | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Retired | 134003730001 | ||||
HARTY, David | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Retired | 134003730001 | ||||
HOMEWOOD, Paul Adrian | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | British | Carpenter | 111718750001 | ||||
HUNTER, William | Amministratore | 31 Park Road Buckden PE19 5SL St Neots Cambridgeshire | British | Interim Manager | 96074400001 | |||||
JOHNSON, Timothy Phillip | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | England | British | Chartered Accountant | 68808980001 | ||||
KALYAPU, Abraham | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | Zambian | Youth Pastor | 121831630001 | ||||
MATHEWS, Rita Elaine | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | District Councillor/Retired Accountant | 64355750002 | ||||
MUIR, Ian Ross | Amministratore | 4a Orchard Way Ramsey PE26 1JF Huntingdon Cambridgeshire | British | Retired | 15102800002 | |||||
OWEN, David Michael | Amministratore | 11 Middlemiss View Godmanchester PE29 2YW Huntingdon Cambridgeshire England | England | British | Insurance Broker | 90034160001 | ||||
PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Amministratore | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | England | British | Director | 46176700002 | ||||
SETCHELL, Jack | Amministratore | 9 Queensway PE19 1EN St. Neots Cambridgeshire | British | Retired Police Officer | 64505090002 | |||||
STEVENS, Thomas Henry | Amministratore | Brook House Ouse Walk PE29 3QW Huntingdon Cambs, | United Kingdom | British | Self Employed | 119367410001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OAK FOUNDATION?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chorus Homes Group Limited | 06 apr 2016 | Cheapside EC2V 6EE London 80 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
OAK FOUNDATION ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 15 ott 2015 Consegnato il 27 ott 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Langley court langley st ives cambridgeshire. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charitable subsidiary fixed charge | Creato il 23 ott 2009 Consegnato il 29 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 31 hill rise st ives CB223978 6 prins avenue wisbech CB140832 20 wintringham road st neots CB250817 please see form for further charges. All buildings and fixtures proceeds of sale covenants moneys paid see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charitable subsidiary fixed charge | Creato il 04 mar 2008 Consegnato il 20 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The properties being 10 bell lane, alconbury t/no CB235645, 8 bell lane, alconbury t/no CB235645, 1 crown gardens, alconbury t/no CB235645. For details of further property charged please refer to form 395. together with all buildings and fixtures, all plant and machinery, all contracts, licences and all oak foundations rights. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A form of charitable subsidiary fixed charge | Creato il 07 apr 2004 Consegnato il 20 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each charitable subsidiary to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all the property being flats 1 to 29 ashtonhouse laburnum avenue incorretly referred to in the property register and title plan as aston house t/n CB254793, 1 to 4 (incl) baron court and 47 to 61 (odd) duloe brook st neots t/n CB253586, 5 to 8 (incl) baron court and 63 to 69 (odd) duloe brook st neots t/n CB253585 by way of first fixed charge all plant and machineryhsbc bank PLC. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0