NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD
Panoramica
| Nome della società | NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04787124 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Indirizzo della sede legale | Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road Bretton CH4 0DH Chester United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CTP (HOLBECK) LIMITED | 23 ago 2011 | 23 ago 2011 |
| CTP ST JAMES (HOLBECK) LIMITED | 14 set 2003 | 14 set 2003 |
| INHOCO 2857 LIMITED | 04 giu 2003 | 04 giu 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Upton come amministratore in data 27 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Matthew Simon Weiner come amministratore in data 27 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Owen Shepherd come amministratore in data 27 ott 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Guy Illingworth come amministratore in data 27 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 7a Howick Place London SW1P 1DZ England a Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road Bretton Chester CH4 0DH in data 27 ott 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Paul Whiteside come segretario in data 27 ott 2020 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Chris Barton come segretario in data 27 ott 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bradley David Cassels come amministratore in data 29 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Marcus Owen Shepherd come amministratore in data 25 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Upton come amministratore in data 25 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Simon Weiner come amministratore in data 25 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 04 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di John Paul Whiteside come segretario in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Paul Whiteside come amministratore in data 31 mar 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Bradley David Cassels come amministratore in data 31 mar 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITESIDE, John Paul | Segretario | Chester Road Bretton CH4 0DH Chester Bradshaws, Charter Court, Well House Barns United Kingdom | 275847830001 | |||||||
| ILLINGWORTH, Guy | Amministratore | Chester Road Bretton CH4 0DH Chester Bradshaws, Charter Court, Well House Barns United Kingdom | United Kingdom | British | 275845500001 | |||||
| BARTON, Chris | Segretario | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | 207220820001 | |||||||
| TONKIN, Timothy Patrick | Segretario | 32 Gledhow Wood Grove LS8 1NZ Leeds West Yorkshire | British | 61274100001 | ||||||
| WHITESIDE, John Paul | Segretario | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | 162815660001 | |||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| CASSELS, Bradley David | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | United Kingdom | British | 130724370005 | |||||
| QUARMBY, James Roger | Amministratore | Arthington Park Arthington LS21 1PH Otley West Yorkshire | England | British | 3103200002 | |||||
| QUARMBY, Oliver Alexander | Amministratore | 4th Floor Bridgewater Place Water Lane LS11 5BZ Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 80707560005 | |||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 41925000003 | |||||
| STROSS, Roland Peter | Amministratore | 4th Floor Bridgewater Place Water Lane LS11 5BZ Leeds West Yorkshire | England | British | 153419870001 | |||||
| TOPHAM, David James | Amministratore | c/o C/O Ctp Limited 7 Jordan Street M15 4PY Manchester Hill Quays United Kingdom | England | British | 92820080001 | |||||
| UPTON, Richard | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| WEINER, Matthew Simon | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||
| WHITESIDE, John Paul | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England | England | British | 16769540006 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northpoint Developments (No 1) Ltd | 06 apr 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a England England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Charge over cash deposit (proceeds account) | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 26 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The deposit and all the present and future titles and benefits of the company whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 24 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All the property known as land and buildings at holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 an DWYK714767. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 24 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Land known as holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 and WYK714767. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over rent account | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 24 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The rent account and all rights, title and benefit in the rent account. The rent account means all sums together with all interest and other monies accruing on such sum standing to the credit of the charged account (sort code 12-08-83 numbered 06970008). see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0