NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD

NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04787124
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road
    Bretton
    CH4 0DH Chester
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CTP (HOLBECK) LIMITED23 ago 201123 ago 2011
    CTP ST JAMES (HOLBECK) LIMITED14 set 200314 set 2003
    INHOCO 2857 LIMITED04 giu 200304 giu 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Cessazione della carica di Richard Upton come amministratore in data 27 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Simon Weiner come amministratore in data 27 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Marcus Owen Shepherd come amministratore in data 27 ott 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Guy Illingworth come amministratore in data 27 ott 2020

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 7a Howick Place London SW1P 1DZ England a Bradshaws, Charter Court, Well House Barns Chester Road Bretton Chester CH4 0DH in data 27 ott 2020

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr John Paul Whiteside come segretario in data 27 ott 2020

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Chris Barton come segretario in data 27 ott 2020

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Bradley David Cassels come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Marcus Owen Shepherd come amministratore in data 25 set 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Upton come amministratore in data 25 set 2017

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Simon Weiner come amministratore in data 25 set 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio annuale redatto al 04 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 giu 2016

    Stato del capitale al 08 giu 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Cessazione della carica di John Paul Whiteside come segretario in data 31 mar 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di John Paul Whiteside come amministratore in data 31 mar 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Bradley David Cassels come amministratore in data 31 mar 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WHITESIDE, John Paul
    Chester Road
    Bretton
    CH4 0DH Chester
    Bradshaws, Charter Court, Well House Barns
    United Kingdom
    Segretario
    Chester Road
    Bretton
    CH4 0DH Chester
    Bradshaws, Charter Court, Well House Barns
    United Kingdom
    275847830001
    ILLINGWORTH, Guy
    Chester Road
    Bretton
    CH4 0DH Chester
    Bradshaws, Charter Court, Well House Barns
    United Kingdom
    Amministratore
    Chester Road
    Bretton
    CH4 0DH Chester
    Bradshaws, Charter Court, Well House Barns
    United Kingdom
    United KingdomBritish275845500001
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    207220820001
    TONKIN, Timothy Patrick
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    32 Gledhow Wood Grove
    LS8 1NZ Leeds
    West Yorkshire
    British61274100001
    WHITESIDE, John Paul
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    162815660001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    United KingdomBritish130724370005
    QUARMBY, James Roger
    Arthington Park
    Arthington
    LS21 1PH Otley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Arthington Park
    Arthington
    LS21 1PH Otley
    West Yorkshire
    EnglandBritish3103200002
    QUARMBY, Oliver Alexander
    4th Floor Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5BZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4th Floor Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5BZ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish80707560005
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish41925000003
    STROSS, Roland Peter
    4th Floor Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5BZ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    4th Floor Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5BZ Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritish153419870001
    TOPHAM, David James
    c/o C/O Ctp Limited
    7 Jordan Street
    M15 4PY Manchester
    Hill Quays
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o C/O Ctp Limited
    7 Jordan Street
    M15 4PY Manchester
    Hill Quays
    United Kingdom
    EnglandBritish92820080001
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    WHITESIDE, John Paul
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    EnglandBritish16769540006
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    England
    06 apr 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    England
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02178560
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    NORTHPOINT DEVELOPMENTS (NO 50) LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over cash deposit (proceeds account)
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 26 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit and all the present and future titles and benefits of the company whatsoever in the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 26 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 24 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All the property known as land and buildings at holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 an DWYK714767. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 24 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land known as holbeck village water lane holbeck leeds t/ns WYK483902, WYK100796, WYK247098, WYK531552 and WYK714767. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over rent account
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 24 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The rent account and all rights, title and benefit in the rent account. The rent account means all sums together with all interest and other monies accruing on such sum standing to the credit of the charged account (sort code 12-08-83 numbered 06970008). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0