INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED

INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04789693
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Cannon Place
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PRECIS (2361) LIMITED06 giu 200306 giu 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 giu 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 giu 2016

    Stato del capitale al 20 giu 2016

    • Capitale: GBP 5,004
    SH01

    Cessazione della carica di Biif Corporate Services Limited come amministratore in data 25 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr John Ivor Cavill come amministratore in data 04 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore in data 04 set 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Biif Corporate Services Limited il 01 lug 2015

    1 pagineCH02

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Dundas & Wilson North West Wing Bush House Aldwych London WC2B 4EZ a Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF in data 01 lug 2015

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital17 giu 2015

    Stato del capitale al 17 giu 2015

    • Capitale: GBP 5,004
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 giu 2014

    Stato del capitale al 27 giu 2014

    • Capitale: GBP 5,004
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nigel Wythen Middleton il 11 nov 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Biif Corporate Services Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Nomina di Mr Nestor Augusto Castillo Borrero come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Forrest come amministratore

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 21 mag 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Forrest il 11 nov 2013

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    11 Thistle Street
    EH2 1DF Edinburgh
    2nd
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione05372427
    128530180002
    CAVILL, John Ivor
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    EnglandBritish152521640008
    MIDDLETON, Nigel Wythen
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    United KingdomBritish156912990002
    LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICES LTD
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Segretario
    100 Wood Street
    EC2V 7EX London
    Fifth Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3388362
    90842510001
    OFFICE ORGANIZATION & SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    Segretario nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Stret
    EC2A 2HS London
    900019420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BELL, Andrew
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    Amministratore
    West Hill Park
    N6 6ND London
    39
    EnglandBritish136926040003
    BUSBY, Colin Ronald William
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    34 Duloe Road
    PE19 8FQ St Neots
    Cambridgeshire
    EnglandBritish109817700001
    CASTILLO BORRERO, Nestor Augusto
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    Amministratore
    16 Palace Street
    SW1E 5JD London
    3i
    United Kingdom
    EnglandBritish182601420001
    ELLIOTT, Christopher James
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish31541950004
    FORREST, Michael
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson
    Aldwych
    WC2B 4EZ London
    North West Wing Bush House
    United KingdomBritish169634490002
    HOGG, Cressida Mary
    W11
    Amministratore
    W11
    EnglandBritish85643820001
    JENNINGS, Oliver James Wake
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    Barclays Bank
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    United KingdomBritish86815910002
    JONES, Nigel Stuart
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    Amministratore
    3 Osprey Court
    Star Place
    E1W 1AG London
    British99472630001
    KING, Neil Edmund
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Annables Manor
    Annables Lane
    AL5 3PR Herpenden
    Hertfordshire
    United KingdomBritish115057710001
    LEATHES, Simon William De Mussenden
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    British9808160003
    MCCLATCHEY, Robert Sean
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    Amministratore
    1 Churchill Place
    E14 5HP London
    Barclays Bank Plc
    United KingdomBritish140441450001
    MONTAGUE, Adrian Alastair, Sir
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    Amministratore
    Gso Business Park
    G74 5PG East Kilbride
    British Energy
    United KingdomBritish70647930007
    RYAN, Michael Joseph
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    Amministratore
    Central Building
    3 Matthew Parker Street
    SW1H 9NE London
    Apartment 42,
    United KingdomIrish77999320003
    SCOTT-BARRETT, Nicholas Huson
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    Amministratore
    Gatehouse Farm
    Crown Lane, Ardleigh
    CO7 7QZ Colchester
    British59658050001
    VICKERSTAFF, Matthew
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    2 Saint Andrews Avenue
    AL5 2RA Harpenden
    Hertfordshire
    British75379800001
    BIIF CORPORATE SERVICES LIMITED
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Amministratore
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06793845
    188111290001
    PEREGRINE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    Amministratore delegato nominato
    Level 1 Exchange House
    Primrose Street
    EC2A 2HS London
    900019410001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    06 apr 2016
    78 Cannon Street
    EC4N 6AF London
    Cannon Place
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06704479
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    INFRASTRUCTURE INVESTORS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2009
    Consegnato il 19 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 19 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ago 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of confirmation
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 06 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and all related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of confirmation
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 06 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares together with the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 29 gen 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from infrastructure investors limited (in its capacity as manager of the borrower under the deed) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first fixed charge its whole right title and interest in and to the shares together with the related rights, the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 20 dic 2007
    Consegnato il 27 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares the related rights, the investments and the receivables,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    Creato il 19 dic 2007
    Consegnato il 28 dic 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The right title and interest in and to the shares and investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Security Trustee for the Other Finance Parties(The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 11 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares together with the related rights; and the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed to deed of charge and assignment dated 21 december 2006
    Creato il 09 nov 2007
    Consegnato il 23 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge its whole right,title and interest in and to the shares together with related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 29 dic 2006
    Consegnato il 06 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the shares together with the related rights,all the investments together with the related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 06 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of charge and assignment
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 05 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the shares in eastbrook facilities holdings 2 limited, normanby healthcare group holdings limited, anavon holdings limited with the related rights meaning all dividends, distributions and other income and all investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC for Itself and as Agent and Trustee for the Other Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 05 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2009Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 24 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0