PHIP (SSG NORWICH) LIMITED

PHIP (SSG NORWICH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPHIP (SSG NORWICH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04795235
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    CATHEDRAL HEALTHCARE (SSG NORWICH) LIMITED28 apr 200428 apr 2004
    MOUNT ANVIL HEALTHCARE (SSG NORWICH) LIMITED11 giu 200311 giu 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 02 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 lug 2014

    Stato del capitale al 30 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy David Walker Arnott il 22 lug 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Abraham Hyman il 22 lug 2014

    2 pagineCH01

    Nomina di Nexus Management Services Limited come segretario in data 01 mag 2014

    3 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da Ryder Court, Ground Floor, 14 Ryder Street London SW1Y 6QB in data 07 mag 2014

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Margaret Helen Vaughan come amministratore in data 30 apr 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jo Hambro Capital Management Limited come segretario in data 30 apr 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Memorandum e Statuto

    4 pagineMEM/ARTS

    legacy

    10 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di James Daryl Hambro come amministratore in data 26 ott 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Philip John Holland come amministratore in data 17 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 11 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Abraham Hyman il 01 gen 2011

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Segretario
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4187765
    57253330002
    HOLLAND, Philip John
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant163838050001
    HYMAN, Harry Abraham
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant35560380005
    WALKER ARNOTT, Timothy David
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor61889360004
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Segretario
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    British81998190003
    JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    United Kingdom
    Segretario
    Ground Floor
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ryder Court
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2176004
    117915530001
    THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    Segretario nominato
    Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    280
    900023410001
    BENNETT, Barry John
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Meadowdown
    Doggetts Wood Close
    HP8 4TL Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomIrishDirector14707370002
    HAMBRO, James Daryl
    Ryder Court, Ground Floor,
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Amministratore
    Ryder Court, Ground Floor,
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritishDirector53684400001
    ISAACS, Paul Samuel
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    Amministratore
    Rosemead
    Woodhill Road
    CM3 4DY Danbury
    Essex
    EnglandBritishDirector141827450001
    NEWMAN, Victor Edward
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    Amministratore
    70 Oakfield Road
    Southgate
    N14 6LX London
    BritishDirector23635170001
    SCOTT, Christopher Richard
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    Amministratore
    Crow Plain Oast House
    Crow Plain Collier Street
    TN12 9PU Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishDirector81998190003
    UPTON, Richard
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    Amministratore
    Old Bearhurst
    Battenhurst Road
    TN5 7DU Stonegate
    East Sussex
    EnglandBritishDirector204950320001
    VAUGHAN, Margaret Helen
    Ryder Court, Ground Floor,
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Amministratore
    Ryder Court, Ground Floor,
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    United KingdomBritishChartered Accountant123167120001
    LUCIENE JAMES LIMITED
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    Amministratore
    280 Gray's Inn Road
    WC1X 8EB London
    77390740003

    PHIP (SSG NORWICH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 02 apr 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 17 mar 2008
    Consegnato il 28 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (For further properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Abbey National Treasury Services PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating security agreement
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks P.L.C.
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 14 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a st stephen's gate medical centre, 55 wessex street norwich t/no NK324282. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 08 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 25 feb 2005
    Consegnato il 08 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H st stephens gate norwich norfolk (the f/h of which is t/no NK234013). Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0