PHIP (SSG NORWICH) LIMITED
Panoramica
Nome della società | PHIP (SSG NORWICH) LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04795235 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 5th Floor Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
CATHEDRAL HEALTHCARE (SSG NORWICH) LIMITED | 28 apr 2004 | 28 apr 2004 |
MOUNT ANVIL HEALTHCARE (SSG NORWICH) LIMITED | 11 giu 2003 | 11 giu 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy David Walker Arnott il 22 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Abraham Hyman il 22 lug 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Nexus Management Services Limited come segretario in data 01 mag 2014 | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Ryder Court, Ground Floor, 14 Ryder Street London SW1Y 6QB in data 07 mag 2014 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Margaret Helen Vaughan come amministratore in data 30 apr 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jo Hambro Capital Management Limited come segretario in data 30 apr 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 4 pagine | MEM/ARTS | ||||||||||
legacy | 10 pagine | MG01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di James Daryl Hambro come amministratore in data 26 ott 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Philip John Holland come amministratore in data 17 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Harry Abraham Hyman il 01 gen 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PHIP (SSG NORWICH) LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Segretario | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England |
| 57253330002 | ||||||||||
HOLLAND, Philip John | Amministratore | Ryder Court 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ground Floor United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 163838050001 | ||||||||
HYMAN, Harry Abraham | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | England | British | Chartered Accountant | 35560380005 | ||||||||
WALKER ARNOTT, Timothy David | Amministratore | Greener House 66-68 Haymarket SW1Y 4RF London 5th Floor England England | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 61889360004 | ||||||||
SCOTT, Christopher Richard | Segretario | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | British | 81998190003 | ||||||||||
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Segretario | Ground Floor 14 Ryder Street SW1Y 6QB London Ryder Court United Kingdom |
| 117915530001 | ||||||||||
THE COMPANY REGISTRATION AGENTS LIMITED | Segretario nominato | Gray's Inn Road WC1X 8EB London 280 | 900023410001 | |||||||||||
BENNETT, Barry John | Amministratore | Meadowdown Doggetts Wood Close HP8 4TL Chalfont St. Giles Buckinghamshire | United Kingdom | Irish | Director | 14707370002 | ||||||||
HAMBRO, James Daryl | Amministratore | Ryder Court, Ground Floor, 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | Director | 53684400001 | ||||||||
ISAACS, Paul Samuel | Amministratore | Rosemead Woodhill Road CM3 4DY Danbury Essex | England | British | Director | 141827450001 | ||||||||
NEWMAN, Victor Edward | Amministratore | 70 Oakfield Road Southgate N14 6LX London | British | Director | 23635170001 | |||||||||
SCOTT, Christopher Richard | Amministratore | Crow Plain Oast House Crow Plain Collier Street TN12 9PU Tonbridge Kent | England | British | Director | 81998190003 | ||||||||
UPTON, Richard | Amministratore | Old Bearhurst Battenhurst Road TN5 7DU Stonegate East Sussex | England | British | Director | 204950320001 | ||||||||
VAUGHAN, Margaret Helen | Amministratore | Ryder Court, Ground Floor, 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 123167120001 | ||||||||
LUCIENE JAMES LIMITED | Amministratore | 280 Gray's Inn Road WC1X 8EB London | 77390740003 |
PHIP (SSG NORWICH) LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 02 apr 2012 Consegnato il 04 apr 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mar 2008 Consegnato il 28 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (For further properties charged please refer to form 395) fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating security agreement | Creato il 01 giu 2007 Consegnato il 14 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 01 giu 2007 Consegnato il 14 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H property k/a st stephen's gate medical centre, 55 wessex street norwich t/no NK324282. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 25 feb 2005 Consegnato il 08 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Legal charge | Creato il 25 feb 2005 Consegnato il 08 mar 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari L/H st stephens gate norwich norfolk (the f/h of which is t/no NK234013). Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0