COLERIDGE (NO.24) LIMITED

COLERIDGE (NO.24) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLERIDGE (NO.24) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04802866
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DWSCO 2408 LIMITED18 giu 200318 giu 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    43 pagine4.71

    Cessazione della carica di Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 24 feb 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1st Floor Unit 16 Manor Court Business Park Scarborough YO11 3TU a The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG in data 13 apr 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 mar 2016

    LRESSP

    Cessazione della carica di Claire Treacy come amministratore in data 05 gen 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Neil Kenneth Robertson come amministratore in data 05 gen 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Fraser James Kennedy come amministratore in data 14 ago 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Claire Treacy come amministratore in data 14 ago 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital26 giu 2015

    Stato del capitale al 26 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2014

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 giu 2014

    Stato del capitale al 20 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2013

    4 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Valsec Director Limited il 01 lug 2013

    2 pagineCH02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Fraser James Kennedy il 01 lug 2013

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Europa House 20 Esplanade Scarborough YO11 2AQ* in data 02 lug 2013

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2012

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Fraser James Kennedy il 05 nov 2012

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di COLERIDGE (NO.24) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    VALAD SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Segretario
    3 Semple Street
    EH3 8BL Edinburgh
    1st Floor Exchange Place 3
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC219311
    133355520001
    VALSEC DIRECTOR LIMITED
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5307786
    102622300002
    RICHARDSON, Paul
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    Segretario
    2 Newdale
    Usher Park Haxby
    YO32 3LN York
    North Yorkshire
    British60649820001
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    DI CIACCA, Cesidio Martin
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    Amministratore
    45 Blairston Avenue
    G71 8SA Bothwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish1267050001
    KENNEDY, Fraser James
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    Amministratore
    Floor
    Unit 16 Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st
    United Kingdom
    United KingdomBritish121610350003
    MCBRIDE, Stephen Paul
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    Amministratore
    Gryffe Main Street
    Upper Poppleton
    YO26 6EL York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish56953000002
    MCCABE, Kevin Charles
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    The White House
    13 Deepdale Avenue
    YO11 2UQ Scarborough
    North Yorkshire
    British109250000001
    OKUNOLA, Abayomi Abiodun
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Amministratore
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish135717740001
    ROBERTSON, Neil Kenneth
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish158937210001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    Amministratore
    64 Clarence Road
    TW11 0BW Teddington
    Middx
    United KingdomBritish41925000003
    TANDY, Didier Michel
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    Amministratore
    9 Warrington Crescent
    W9 1ED London
    EnglandBritish69909950001
    TREACY, Claire
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    Unit 16
    Manor Court Business Park
    YO11 3TU Scarborough
    1st Floor
    United Kingdom
    United KingdomIrish189529610001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Amministratore delegato nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001
    EUROPA DIRECTOR LIMITED
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    102560510001

    COLERIDGE (NO.24) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 22 mar 2012
    Consegnato il 30 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 30 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creato il 28 ago 2009
    Consegnato il 11 set 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company’s and any other chargor’s indebtedness to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All land in england and wales,all its rights at the accession deed date,all trade debts and other debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 11 set 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 23 lug 2003
    Consegnato il 30 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 lug 2003
    Consegnato il 30 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all the l/h property known as 67-75 (odd numbers) kingsway, london WC2. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 30 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    COLERIDGE (NO.24) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 mar 2016Inizio della liquidazione
    29 lug 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul David Williams
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    Duff & Phelps Ltd The Shard
    32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Geoffrey Wayne Bouchier
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London
    Praticante
    The Shard,32 London Bridge Street
    SE1 9SG London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0