ACTIVE IQ LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàACTIVE IQ LIMITED
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04813840
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ACTIVE IQ LIMITED?

    • Servizi di supporto all'istruzione (85600) / Istruzione

    Dove si trova ACTIVE IQ LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Q6 Quorum Park
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ACTIVE IQ LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PREMIER I Q LIMITED27 giu 200327 giu 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di ACTIVE IQ LIMITED?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 lug 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il30 apr 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ACTIVE IQ LIMITED?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al29 mar 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma12 apr 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al29 mar 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per ACTIVE IQ LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2024

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 lug 2023

    20 pagineAA
    Note
    DataNota
    29 apr 2024Part Admin Removed The Detailed Income Statement on the Annual Report and Financial Statements for the Period from 23 November 2022 to 31 July 2023 were administratively removed from the public register on 29/04/2024 as the material was not properly delivered

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 22 nov 2023 al 31 lug 2023

    1 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 22 nov 2022

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 mar 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di David James Gallagher come persona con controllo significativo il 22 nov 2022

    2 paginePSC01

    Notifica di Kristoffer Todd come persona con controllo significativo il 22 nov 2022

    2 paginePSC01

    Nomina di Mrs Emma Jane Hoare come segretario in data 02 mar 2023

    2 pagineAP03

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2022 al 22 nov 2022

    1 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da Dryden House St. Johns Street Huntingdon PE29 3NU England a Q6 Quorum Park Benton Lane Newcastle upon Tyne NE12 8BT in data 30 nov 2022

    1 pagineAD01

    Memorandum e Statuto

    8 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Mr Kristoffer Todd come amministratore in data 22 nov 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Gregory Sebasky come amministratore in data 22 nov 2022

    1 pagineTM01

    Nomina di David Gallagher come amministratore in data 22 nov 2022

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mandeep Singh Johar come amministratore in data 22 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Lawrence Adam Gold come amministratore in data 22 nov 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Timothy Wendon-Evans come segretario in data 22 nov 2022

    1 pagineTM02

    Cessazione di Ascend Learning Uk Limited come persona con controllo significativo il 22 nov 2022

    1 paginePSC07

    Notifica di Ncfe come persona con controllo significativo il 22 nov 2022

    2 paginePSC02

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    22 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Ascend Learning Uk Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 giu 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ACTIVE IQ LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOARE, Emma Jane
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    Segretario
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    306591010001
    GALLAGHER, David James
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Executive Officer302756720001
    TODD, Kristoffer
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    Amministratore
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer269057980001
    COOK, Fiona Lesley
    The Anderson Centre
    Ermine Business Park
    PE29 6XY Huntingdon
    Westminster House
    Cambridgeshire
    England
    Segretario
    The Anderson Centre
    Ermine Business Park
    PE29 6XY Huntingdon
    Westminster House
    Cambridgeshire
    England
    154380610001
    EDWARDS, Michael Ian
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Segretario
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    151043710001
    GOUGH, Tracey
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Segretario
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    206677640001
    OAKEY, Douglas Malcolm Andrew
    1 The Stables
    The Butts
    BA13 3JT Westbury
    Wiltshire
    Segretario
    1 The Stables
    The Butts
    BA13 3JT Westbury
    Wiltshire
    BritishCompany Secretary56081250002
    ROGERS, Phillip John
    26 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Bath And North East Somerset
    Segretario
    26 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglishAccountant94474860001
    STUART, Debra-Lynn
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Segretario
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    149151920001
    WENDON-EVANS, Timothy
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Segretario
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    284764650001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    BASSON, Jane Belinda
    1 St Lukes Road
    Beckington
    BA11 6SE Frome
    Somerset
    Amministratore
    1 St Lukes Road
    Beckington
    BA11 6SE Frome
    Somerset
    BritishDirector112889610001
    BERRIMAN, Julian Paul
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector148185750001
    BROMILOW, Carl Anthony
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector215809910001
    COLEMAN, Neale Paul
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishCommercial Director180384030002
    CONAWAY, Eric
    Overbrook Road
    KS 66211 Leawood
    11161
    United States
    Amministratore
    Overbrook Road
    KS 66211 Leawood
    11161
    United States
    United StatesAmericanVp Financial Planning & Analysis245137570001
    EDMONDS, Sarah Jane
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    EnglandBritishDirector203497790001
    EDWARDS, Michael Ian
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    Amministratore
    Willow Side Park
    Canal Road
    BA14 8RH Trowbridge
    Wiltshire
    EnglandBritishDirector151050100001
    GOLD, Lawrence Adam
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    United StatesAmericanLegal Counsel251803470002
    GUNN, Suzanne Elizabeth
    The Anderson Centre
    Ermine Business Park
    PE29 6XY Huntingdon
    Westminster House
    Cambridgeshire
    England
    Amministratore
    The Anderson Centre
    Ermine Business Park
    PE29 6XY Huntingdon
    Westminster House
    Cambridgeshire
    England
    EnglandBritishDirector129393200003
    JOHAR, Mandeep Singh
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    United StatesBritishAccountant251804350001
    MAY, Mark Allan
    c/o Ascend Learning - Finance Team
    Overbrook Road
    KS 66211 Leawood
    11161
    Kansas
    United States
    Amministratore
    c/o Ascend Learning - Finance Team
    Overbrook Road
    KS 66211 Leawood
    11161
    Kansas
    United States
    United StatesAmericanAccountant259112090001
    MCPHERSON, James Alexander
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    EnglandBritishCommercial Director245502520002
    MONK, Jennifer
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    EnglandBritishDirector185166070002
    ROGERS, Phillip John
    26 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Bath And North East Somerset
    Amministratore
    26 Naishes Avenue
    Peasedown St John
    BA2 8TW Bath
    Bath And North East Somerset
    EnglandEnglishDirector94474860001
    SEBASKY, Gregory
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    United StatesAmericanCeo295932610001
    SHAW, Georgina Suzanne
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Amministratore
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    EnglandBritishDirector Of Quality & Standards224223930001
    STUART, Debra Lynn
    8 Weir Close
    PE28 9EJ Hemingford Grey
    Cambridgeshire
    Amministratore
    8 Weir Close
    PE28 9EJ Hemingford Grey
    Cambridgeshire
    BritishDirector115661490001
    WADE, Jason
    Overbrook Road
    Leawood
    11161
    Ks 66211
    Usa
    Amministratore
    Overbrook Road
    Leawood
    11161
    Ks 66211
    Usa
    United StatesAmericanFinancial Controller244919110001
    WATTS, Christopher John
    Bridge House
    Felindre
    LD3 0SU Brecon
    Powys
    Amministratore
    Bridge House
    Felindre
    LD3 0SU Brecon
    Powys
    BritishCo Director4053630004
    WILLIAMS, Beverley
    50 Wingfield Road
    BA14 9EN Trowbridge
    Amministratore
    50 Wingfield Road
    BA14 9EN Trowbridge
    BritishDirector80101470002
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ACTIVE IQ LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Kristoffer Todd
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    22 nov 2022
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Mr David James Gallagher
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    22 nov 2022
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 50% ma non più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    22 nov 2022
    Benton Lane
    NE12 8BT Newcastle Upon Tyne
    Q6 Quorum Park
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company By Guarantee Without Share Capital Use Of 'Limited' Exemption
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02896700
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Ascend Learning Uk Limited
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    06 apr 2016
    St. Johns Street
    PE29 3NU Huntingdon
    Dryden House
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Registry Of Companies
    Numero di registrazione04150192
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0