ORIEL RESOURCES LIMITED

ORIEL RESOURCES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàORIEL RESOURCES LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04818143
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di ORIEL RESOURCES LIMITED?

    • Estrazione di altri minerali metallici non ferrosi (07290) / Attività estrattive

    Dove si trova ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    64 North Row
    W1K 7DA London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ORIEL RESOURCES PLC02 lug 200302 lug 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 dic 2022
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2023
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al01 gen 2025
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma15 gen 2025
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al01 gen 2024
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 02 feb 2024

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da 17 Hanover Square London W1S 1BN United Kingdom a 64 North Row London W1K 7DA in data 12 feb 2024

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da , 33 Cavendish Square, London, W1G 0PW a 17 Hanover Square London W1S 1BN in data 26 giu 2023

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 33 Cavendish Square London W1G 0PW

    1 pagineAD04

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    23 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 048181430012 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 gen 2022 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 23 ago 2021

    • Capitale: GBP 8,553,321.31
    4 pagineSH06

    Acquisto di azioni proprie.

    3 pagineSH03
    Note
    DataNota
    18 ott 2021Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Dichiarazione degli amministratori e relazione dei revisori dei conti. A carico del capitale

    2 pagineSH30

    Dichiarazione degli amministratori e relazione dei revisori dei conti. A carico del capitale

    3 pagineSH30

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di autorità per acquistare azioni proprie dal capitale

    RES08

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Mechel Pao come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Notifica di Mechel Pao come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Cessazione di Igor Vladimirovich Zyuzin come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC07

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARCZA, Nicholas Adrian, Dr
    North Row
    W1K 7DA London
    64
    Amministratore
    North Row
    W1K 7DA London
    64
    United KingdomSouth AfricanEngineer160640570001
    KOTECHA, Manish Suresh
    55 Marlborough Hill
    HA1 1TX Harrow
    Middlesex
    Segretario
    55 Marlborough Hill
    HA1 1TX Harrow
    Middlesex
    BritishFinancial Control83346120001
    MARTIN, Irina
    103 Burgoyne Road
    TW16 7PS Sunbury On Thames
    Middlesex
    Segretario
    103 Burgoyne Road
    TW16 7PS Sunbury On Thames
    Middlesex
    BritishCompany Secretary95590270001
    PEREDERIY, Ekaterina Gennadievna
    Krasnoarmeyskaya
    Moscow
    1
    Russia
    Segretario
    Krasnoarmeyskaya
    Moscow
    1
    Russia
    182753200001
    PROKOPYUK, Dmitry Vasilievich
    Building 2 Flat 186
    Marshal Biruzov Street
    123298 Moscow
    8,
    Russian Federation
    Segretario
    Building 2 Flat 186
    Marshal Biruzov Street
    123298 Moscow
    8,
    Russian Federation
    OtherLawyer131186230001
    SWAN, David John
    Hextalls Lane
    RH1 4QT Bletchingley
    White Rose Farm
    Surrey
    Segretario
    Hextalls Lane
    RH1 4QT Bletchingley
    White Rose Farm
    Surrey
    AustralianCompany Secretary169581740001
    SCRIP SECRETARIES LIMITED
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    Segretario
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    74920110001
    ST JAMES'S SQUARE SECRETARIES LIMITED
    7 Savoy Court
    Strand
    WC2R 0ER London
    Segretario
    7 Savoy Court
    Strand
    WC2R 0ER London
    70351810003
    BAKER, Edward Max
    Apt 12 1027 Lynn Valley Road
    North Vancouver
    British Columbia V7j 1z6
    Canada
    Amministratore
    Apt 12 1027 Lynn Valley Road
    North Vancouver
    British Columbia V7j 1z6
    Canada
    CanadianGeologist93655040001
    BARATOV, Takhirzhan Tursunovich
    Flat 3
    33 Zhetysu-2
    Almaty
    Kazakhstan
    Amministratore
    Flat 3
    33 Zhetysu-2
    Almaty
    Kazakhstan
    KazakhstanDirector132786340001
    BARCZA, Nicholas Adrian, Dr
    3 Lucas Street, Bryanbrink
    Randburg
    Gauteng 2194
    South Africa
    Amministratore
    3 Lucas Street, Bryanbrink
    Randburg
    Gauteng 2194
    South Africa
    South AfricanEngineer Manager101269110001
    BUSH, Geoffrey Thomas
    Silverstone
    BN5 9LP Edburton
    West Sussex
    Amministratore
    Silverstone
    BN5 9LP Edburton
    West Sussex
    EnglandBritishDirector66883230001
    CLARKE, Nicholas Royston
    2 Tremayne Close
    Devoran
    TR3 6QE Truro
    Cornwall
    Amministratore
    2 Tremayne Close
    Devoran
    TR3 6QE Truro
    Cornwall
    United KingdomBritishGeologist51046830001
    DATTELS, Stephen Roland
    Flat E
    10 Upper Grosvenor Street
    W1K 2NA London
    Amministratore
    Flat E
    10 Upper Grosvenor Street
    W1K 2NA London
    CanadianInvestment Banker80373750001
    DOUGLAS, Daniel Conleith
    56 Ullswater Road
    SW13 9PN London
    Amministratore
    56 Ullswater Road
    SW13 9PN London
    BritishDirector94475790001
    HUSSEY, William John
    Chycoose
    South Tehidy
    TR14 0HU Camborne
    Cornwall
    Amministratore
    Chycoose
    South Tehidy
    TR14 0HU Camborne
    Cornwall
    EnglandBritishMining Engineer35710720001
    IVANUSHKIN, Alexey Gennadievich
    Armyansky Pereulok
    Moscow
    Flat. 8, 7
    101000
    Russian Federation
    Amministratore
    Armyansky Pereulok
    Moscow
    Flat. 8, 7
    101000
    Russian Federation
    Russian FederationRussianDirector134157150001
    KOTECHA, Manish Suresh
    55 Marlborough Hill
    HA1 1TX Harrow
    Middlesex
    Amministratore
    55 Marlborough Hill
    HA1 1TX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritishFinancial Control83346120001
    KURZIN, Sergey Vladimirovich, Dr
    Arling House
    Rye Hill
    TN31 7NH Rye
    East Sussex
    Amministratore
    Arling House
    Rye Hill
    TN31 7NH Rye
    East Sussex
    United KingdomBritish,RussianMining Consultant48805810002
    MACKENZIE OF FRAMWELLGATE, Brian, Lord
    Woodland View 14 St Mary`S Close
    Shincliffe Village
    DH1 2ND Durham City
    Amministratore
    Woodland View 14 St Mary`S Close
    Shincliffe Village
    DH1 2ND Durham City
    United KingdomBritishDirector95737620004
    NESIS, Alexander Natanovich
    Flat 77, 51 5 Mikroraion Street
    Tikhvin
    Leningrad Area
    187550
    Russia
    Amministratore
    Flat 77, 51 5 Mikroraion Street
    Tikhvin
    Leningrad Area
    187550
    Russia
    RussianDirector117784750001
    REYNOLDS, John Douglas
    R.R.
    1230 St Andrews Road
    V0N 1V1 Gibsons
    Bc
    Canada
    Amministratore
    R.R.
    1230 St Andrews Road
    V0N 1V1 Gibsons
    Bc
    Canada
    CanadianMember Of Parliament103738610002
    RICHER, Roger Thomas
    5549 Cypress Street
    FOREIGN Vancouver
    Bc V6m 3r5
    Canada
    Amministratore
    5549 Cypress Street
    FOREIGN Vancouver
    Bc V6m 3r5
    Canada
    CanadianGeneral Counsel104141250001
    RIEGER, Ehud
    60 Mota Gur St
    Tel Aviv
    69012
    Istael
    Amministratore
    60 Mota Gur St
    Tel Aviv
    69012
    Istael
    BritishDirector117744280001
    SWAN, David John
    W1G 0PW London
    33 Cavendish Square
    United Kingdom
    Amministratore
    W1G 0PW London
    33 Cavendish Square
    United Kingdom
    United KingdomAustralianFinancial Accountant169581740001
    SWAN, David John
    Hextalls Lane
    RH1 4QT Bletchingley
    White Rose Farm
    Surrey
    Amministratore
    Hextalls Lane
    RH1 4QT Bletchingley
    White Rose Farm
    Surrey
    United KingdomAustralianCompany Secretary169581740001
    TAYLOR, Sebastian John Breden
    Chalet Kranick
    3782
    Lavenen
    Switzerland
    Amministratore
    Chalet Kranick
    3782
    Lavenen
    Switzerland
    SwitzerlandBritishConsultant248864260001
    WILSON, Paul Craig
    Sundridge Hill
    TN14 7PP Knockholt
    Knockholt Lodge
    Kent
    Amministratore
    Sundridge Hill
    TN14 7PP Knockholt
    Knockholt Lodge
    Kent
    BritishDirector133802910002
    WOODYER, Neil
    Studio 8 Las Casitas
    214 Palm Heights Drive PO BOX 1793
    Grand Cayman
    Ky1 1109
    Caymanislands
    Amministratore
    Studio 8 Las Casitas
    214 Palm Heights Drive PO BOX 1793
    Grand Cayman
    Ky1 1109
    Caymanislands
    Canada BritishDirector117712820001
    ST JAMES'S SQUARE DIRECTORS LIMITED
    Strand
    WC2R 1DJ London
    200
    Amministratore
    Strand
    WC2R 1DJ London
    200
    123277260001
    ST JAMES'S SQUARE SECRETARIES LIMITED
    7 Savoy Court
    Strand
    WC2R 0ER London
    Amministratore
    7 Savoy Court
    Strand
    WC2R 0ER London
    70351810003

    Chi sono le persone con controllo significativo di ORIEL RESOURCES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Igor Vladimirovich Zyuzin
    1 Krasnoarmeyskaya St.
    Moscow125167
    Mechel
    Russia Federation
    06 apr 2016
    1 Krasnoarmeyskaya St.
    Moscow125167
    Mechel
    Russia Federation
    Nazionalità: Russian
    Paese di residenza: Russia
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Igor Vladimirovich Zyuzin
    1 Krasnoarmeyskaya St.
    Moscow125167
    Mechel
    Russian Federation
    06 apr 2016
    1 Krasnoarmeyskaya St.
    Moscow125167
    Mechel
    Russian Federation
    Nazionalità: Russian
    Paese di residenza: Russia
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mechel Pao
    1
    125167 Moscow
    Krasnoarmeyskaya Street
    Russia
    06 apr 2016
    1
    125167 Moscow
    Krasnoarmeyskaya Street
    Russia
    No
    Forma giuridicaPao
    Paese di registrazioneRussia
    Autorità legaleThe Civil Code
    Luogo di registrazioneRussian Federation
    Numero di registrazione1037703012896
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ORIEL RESOURCES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 13 mag 2014
    Consegnato il 16 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 feb 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Agreement on pledge of shares
    Creato il 06 set 2010
    Consegnato il 16 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee as joint & several creditor of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    As security for the performance of the secured obligations under the secured obligations to the full esxtent including any interest, penalty or indemnity in respect of losses arising from delay in performance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Unicredit Bank Ag as Joint & Several Creditor of the Finance Parties
    Transazioni
    • 16 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Shares pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Creato il 11 mar 2010
    Consegnato il 31 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from open-joint stock company "southern kuzbass coal company" to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subject of the pledge being- 149, 936 common shares, each with a par value of one ruble and state reg no: 1-01-00197-a see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jsc Vtb Bank
    Transazioni
    • 31 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Shares pledge agreement executed outside the united kingdom over property situated there
    Creato il 11 mar 2010
    Consegnato il 31 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from open-joint stock company "holding company"yakutugol" to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Subject of the pledge being- 149, 936 common shares, each with a par value of one ruble and state reg no: 1-01-00197-a see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jsc Vtb Bank
    Transazioni
    • 31 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 12 giu 2007
    Consegnato il 26 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights in and to the investments. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westlb, London Branch (The Offshore Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A deed of subordination and assignment
    Creato il 12 giu 2007
    Consegnato il 26 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and benefits and claims under the assigned agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Westlb Ag, London Branch (The Offshore Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 14 mag 2007
    Consegnato il 22 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 20629427 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 22 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 30 nov 2006
    Consegnato il 05 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 23770872 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge of deposit
    Creato il 10 mar 2006
    Consegnato il 17 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All deposits now and in the future credited to account designation 20605668 with the bank and any deposit or account of any other description or designation which derives in whole or in part from such deposits or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 17 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 feb 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge of deposit
    Creato il 24 gen 2005
    Consegnato il 10 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of $15,094,603.18 credited to account designation 140/01/50673467 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 10 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 12 mar 2004
    Consegnato il 18 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £50,113 credited to account designation 10463186 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge of deposit
    Creato il 13 gen 2004
    Consegnato il 16 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The deposit initially of £60,000 credited to account designation 20548265 with the bank and any addition to that deposit and any deposit or account from time to time of any other currency description or designation which derives in whole or in part from such deposit or account.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ORIEL RESOURCES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    02 feb 2024Inizio della liquidazione
    02 feb 2024Data della dichiarazione di solvibilità giurata
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Joanne Elizabeth Milner
    64 North Row
    W1K 7DA London
    Praticante
    64 North Row
    W1K 7DA London
    David J Buchler
    64 North Row
    W1K 7DA London
    Praticante
    64 North Row
    W1K 7DA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0