NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED

NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04822197
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Beauchamp Court
    Victors Way
    EN5 5TZ Barnet
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 05 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 lug 2013

    Stato del capitale al 16 lug 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2012

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 05 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2011

    6 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 05 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2010

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Indirizzo della sede legale modificato da * 13 Manor Road Chigwell Essex IG7 5PF United Kingdom* in data 15 set 2010

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Newbury House 900 Eastern Avenue Newbury Park Ilford Essex IG2 7HH* in data 15 set 2010

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2009

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2008

    4 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2007

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 lug 2006

    4 pagineAA

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 lug 2005

    4 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WINTER, Alan Lawrence
    13 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    Segretario
    13 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    BritishSolicitor61864280003
    PEACE, Nicolas Barrington
    Newbury House
    900 Eastern Avenue Newbury
    IG2 7HH Ilford
    Essex
    Amministratore
    Newbury House
    900 Eastern Avenue Newbury
    IG2 7HH Ilford
    Essex
    BritishSolicitor29309680002
    ROBIN, Itzik
    45 Forest Lane
    IG7 5AF Chigwell
    Essex
    Amministratore
    45 Forest Lane
    IG7 5AF Chigwell
    Essex
    United KingdomBritishCo Director14859360002
    WINTER, Alan Lawrence
    13 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    Amministratore
    13 Manor Road
    IG7 5PF Chigwell
    Essex
    EnglandBritishSolicitor61864280003
    BHARDWAJ, Ashok
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Segretario nominato
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    British900010640001
    BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    Amministratore delegato nominato
    47-49 Green Lane
    HA6 3AE Northwood
    Middlesex
    900010630001

    NEWBURY HOUSE NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leeds & Holbeck Building Society
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge deed
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Newbury house 890-900 eastern avenue newbury park ilford essex. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leeds & Holbeck Building Society
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of rental assignment
    Creato il 24 mar 2005
    Consegnato il 08 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Leeds & Holbeck Building Society
    Transazioni
    • 08 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 set 2003
    Consegnato il 24 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property known as newbury house, eastern avenue, ilford, essex. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 feb 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0