AA ASSISTANCE LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AA ASSISTANCE LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04823689 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AA ASSISTANCE LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova AA ASSISTANCE LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AA ASSISTANCE LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| VOLKSWAGEN ASSISTANCE LIMITED | 15 ago 2003 | 15 ago 2003 |
| VW ASSISTANCE LIMITED | 06 ago 2003 | 06 ago 2003 |
| AA ASSISTANCE LIMITED | 07 lug 2003 | 07 lug 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AA ASSISTANCE LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per AA ASSISTANCE LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2017 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Miss Marianne Neville come amministratore in data 03 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 giu 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Gillian Pritchard il 30 apr 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert James Scott come amministratore in data 30 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Gillian Pritchard come amministratore in data 30 apr 2016 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mrs Catherine Zawada il 21 gen 2016 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Catherine Zawada come segretario in data 05 ago 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Taguma Ngondonga come segretario in data 05 ago 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 giu 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert James Scott il 20 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Kenneth Boland come amministratore in data 19 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Mark Falcon Millar come amministratore in data 16 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 gen 2014 | 4 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Robert James Scott il 08 ago 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 07 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Taguma Ngondonga come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Victoria Haynes come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Robert James Scott il 02 feb 2014 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AA ASSISTANCE LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMMOND, Catherine | Segretario | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | 200487760002 | |||||||
| MILLAR, Mark Falcon | Amministratore | Basing View Basingstoke RG21 4EA Hants Fanum House United Kingdom | England | British | 84701400002 | |||||
| NEVILLE, Marianne | Amministratore | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | England | British | 235099440001 | |||||
| PRITCHARD, Gillian Rosemary | Amministratore | Fanum House Basing View RG21 4EA Basingstoke Hampshire | England | British | 208086500001 | |||||
| DAVIES, John | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 115843280001 | ||||||
| HAYNES, Victoria | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | British | 182412280001 | ||||||
| NGONDONGA, Taguma | Segretario | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | 187303670001 | |||||||
| STRINGER, Andrew Paul | Segretario | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | 171546690001 | |||||||
| TROUSDALE, Carolyn | Segretario | 2 Oak Tree Cottage Brick Hill GU24 8TG Chobham Surrey | British | 105870180001 | ||||||
| CENTRICA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Millstream Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Berkshire | 71532760003 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED | Segretario | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 83911920002 | |||||||
| RM REGISTRARS LIMITED | Segretario | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Hertfordshire | 39155760003 | |||||||
| BOLAND, Andrew Kenneth | Amministratore | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 71264540006 | |||||
| CHINN, Trevor Edwin, Sir | Amministratore | Flat 29 7 Princes Gate SW7 1QL London | British | 19150700001 | ||||||
| HOWARD, Stuart Michael | Amministratore | 2 Enbrook Park CT20 3SE Folkestone Kent | United Kingdom | British | 160271430001 | |||||
| MURPHY, Thomas Jerome Peter | Amministratore | 9 One Tree Lane HP9 2BU Beaconsfield Buckinghamshire | British | 76945730001 | ||||||
| PARKER, Timothy Charles | Amministratore | Southwood East Apollo Rise GU14 0JW Farnborough Hampshire | United Kingdom | British | 122029390001 | |||||
| RICHARDSON, Kerry Francis | Amministratore | 7 Torland Drive Oxshott KT22 0SA Leatherhead Surrey | England | British | 20890680002 | |||||
| SCOTT, Robert James | Amministratore | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire United Kingdom | England | British | 104000820011 | |||||
| STRONG, Andrew Jonathan Peter | Amministratore | Sandgate CT20 3SE Folkestone Enbrook Park Kent United Kingdom | United Kingdom | British | 68169450005 | |||||
| WOOLF, Paul Antony | Amministratore | Freemantle King Lane SO20 8JE Over Wallop Hampshire | United Kingdom | British | 160679880001 | |||||
| WOOLF, Paul Antony | Amministratore | 18 Fairfax Road W4 1EW London | British | 78818510001 | ||||||
| RM NOMINEES LIMITED | Amministratore | Invision House Wilbury Way SG4 0TW Hitchin Hertfordshire | 57338730003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AA ASSISTANCE LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automobile Association Developments Limited | 06 apr 2016 | Basing View RG21 4EA Basingstoke Fanum House Hampshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
AA ASSISTANCE LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 20 apr 2007 Consegnato il 04 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 14 mar 2006 Consegnato il 25 mar 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 30 set 2004 Consegnato il 15 ott 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0