OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPAL PORTFOLIO 3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04824858
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2018

    7 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2017

    7 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da The Place Ducie Street Manchester M1 2TP a 15 Canada Square London E14 5GL in data 20 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2016

    LRESSP

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    47 pagine1.4

    Nomina di Mr Richard James Spencer come amministratore in data 04 giu 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brett Alan Lashley come amministratore in data 04 giu 2015

    2 pagineTM01

    Nomina di Brett Alan Lashley come amministratore in data 25 feb 2015

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Craig Allan Mellor come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gavin Robert Duncan come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Criag Allan Mellor come segretario in data 25 feb 2015

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Stuart Barrie Wall come amministratore in data 25 feb 2015

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Kpmg Llp 8 Salisbury Square London EC4Y 8BB a The Place Ducie Street Manchester M1 2TP in data 06 mar 2015

    2 pagineAD01

    Avviso di termine dell'amministrazione

    74 pagine2.32B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 gen 2015

    67 pagine2.24B

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    9 pagine1.1

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 lug 2014

    90 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 10 gen 2014

    65 pagine2.24B

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    1 pagine2.31B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 17 set 2013

    77 pagine2.24B

    Chi sono gli amministratori di OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SPENCER, Richard James
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    Amministratore
    Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court 133
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish190526870001
    DRAPER, Abigail Sarah
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    Segretario
    265 Chester Road, Helsby
    WA6 0PN Frodsham
    Cheshire
    British107928180001
    HARRISON, Irene Lesley
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    Segretario nominato
    Fy Mwthin
    22 Merthyr Road Tongwynlais
    CF15 7LH Cardiff
    South Glamorgan
    British900003790001
    MELLOR, Criag Allan
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    Segretario
    21 Queenston Road
    M20 2NX Manchester
    Lancashire
    British100890520001
    DUNCAN, Gavin Robert
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish151512820001
    LASHLEY, Brett Alan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandUnited States Of America196201790001
    MARTIN, Graham Hunter
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Rosegarth
    51 Adlington Road
    SK9 2BJ Wilmslow
    Cheshire
    British87259480001
    MELLOR, Craig Allan
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    Amministratore
    Ducie Street
    M1 2TP Manchester
    The Place
    EnglandBritish60906780002
    SMITH, David Ryder
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    Amministratore
    5 Acacia Avenue
    WA15 8QX Hale
    Cheshire
    EnglandBritish202067380001
    WALL, Stuart Barrie
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Old Acres
    Well Bank Lane Over Peover
    WA16 8UN Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95010340001
    BUSINESS INFORMATION RESEARCH & REPORTING LIMITED
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    Crown House
    64 Whitchurch Road
    CF14 3LX Cardiff
    900005500001

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 04 apr 2012
    Consegnato il 19 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Pitfield street youth centre, pitfield street t/no EGL438260. Lyme view, 17 buxton road west, disley t/no CH519650. Land and buildings on the south east side of granby row t/no LA378335. (For further details of properties charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Bank Resolution Corporation Limited
    Transazioni
    • 19 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The f/h land and buildings k/a condor works located on the north side of rusholme place, manchester t/n LA187336, by way of assignment the gross rents licence fees and other monies; by way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Asset Finance PLC
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 26 set 2003
    Consegnato il 10 ott 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the f/h property k/a wilmslow park wilmslow road manchester t/no GM683090 and opal court de montfort street leicester t/no LT27667 and including all rights and buildings fixtures fittings plant and machinery, the gross rents licence fees and other monies receivable, the benefit of all guarantees and all and any agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 10 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 25 set 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN362302, the f/h property k/a 6 windsor villas lockyer street plymouth t/n DN233238, the f/h property k/a phoenix house notte street plymouth and t/n DN303418. The gross rent licence fees and other monies , the benefit of all guarantees warranties and representations, the benefit of all and any agreements relating to the property and the goodwill. By way of floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 25 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    OPAL PORTFOLIO 3 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    18 mar 2013Inizio dell'amministrazione
    20 feb 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praticante
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    2
    DataTipo
    12 dic 2014Data della riunione per approvare il CVA
    22 ott 2015Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Brian Green
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Colin Michael Trevethyn Haig
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    4
    DataTipo
    30 set 2016Inizio della liquidazione
    22 ago 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0