20:20 MOBILE (UK) LIMITED

20:20 MOBILE (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della società20:20 MOBILE (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04833552
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    20:20 LOGISTICS LIMITED05 gen 200405 gen 2004
    K & S (511) LIMITED15 lug 200315 lug 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    8 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 dic 2019

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 dic 2018

    9 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 dic 2017

    11 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:notice of release of former liquidator by secretary of state in mvl or cvl
    4 pagineLIQ MISC

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    15 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 dic 2016

    8 pagine4.68

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 10 dic 2015

    8 pagine4.68

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 11 dic 2014

    LRESSP

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    12 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    12 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di James Browning come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Meinie Oldersma come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Keith Ellis come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew White come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    19 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 18 dic 2013

    • Capitale: GBP 2
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di 20:20 MOBILE (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMITH, Nicholas Alexander
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Segretario
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    British128521390002
    ELLIS, Robert Keith
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    EnglandBritish154853690001
    SMITH, Nicholas Alexander
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    United KingdomBritish128521390002
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Segretario
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    British34704080002
    MOULDING, Matthew John
    33 Registry Close
    Kingsmead
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    Segretario
    33 Registry Close
    Kingsmead
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    British116013430001
    K & S SECRETARIES LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Segretario nominato
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006940001
    BAXENDALE, Richard
    33 Longbourn
    SL4 3TN Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    33 Longbourn
    SL4 3TN Windsor
    Berkshire
    EnglandBritish86868810002
    BENNETT, Craig
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    Amministratore
    Merry Fox
    Hall Lane
    WA16 7AH Mobberley
    Cheshire
    United KingdomBritish34704080002
    BROWNING, James Scott
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    United KingdomBritish107639370001
    CAUDWELL, Brian, Mr.
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Brooklands
    Sarisbury Green
    SO31 7EE Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish15920410004
    CAUDWELL, John David
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    Amministratore
    Broughton Hall
    Broughton
    ST21 6NS Eccleshall
    Staffordshire
    EnglandBritish21185880002
    GUPTA, Prakash Kumar
    60 Chestnut Road
    Loggerheads
    TF9 4RF Market Drayton
    Oak Cottage
    Shropshire
    Amministratore
    60 Chestnut Road
    Loggerheads
    TF9 4RF Market Drayton
    Oak Cottage
    Shropshire
    EnglandBritish62671990002
    HUBBARD, Peter John
    Portridge House
    Old Burghclere
    RG20 9NH Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Portridge House
    Old Burghclere
    RG20 9NH Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish146285880001
    MILLAR, Roderick John
    77 Sandbach Road North
    Alsager
    ST7 2AP Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    77 Sandbach Road North
    Alsager
    ST7 2AP Stoke On Trent
    Staffordshire
    UkBritish153972110001
    MOULDING, Matthew John
    33 Registry Close
    Kingsmead
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    33 Registry Close
    Kingsmead
    CW9 8UZ Northwich
    Cheshire
    British116013430001
    OLDERSMA, Meinie, Mr.
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    United KingdomThe Netherlands127482400003
    RYAN, Mark Stephen Edward
    The Old Hall
    Little Heath Road, Christleton
    CH3 7AH Chester
    Cheshire
    Amministratore
    The Old Hall
    Little Heath Road, Christleton
    CH3 7AH Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish142752190001
    STEPHENSON, Christopher
    242 Brooklands Road
    M23 9HD Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    242 Brooklands Road
    M23 9HD Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritish102868610001
    WHITE, Andrew Mark
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    Amministratore
    Weston Road
    Crewe
    CW1 6BU Cheshire
    EnglandBritish230126680001
    K & S DIRECTORS LIMITED
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    Amministratore delegato nominato
    The Brampton
    ST5 0QW Newcastle-Under-Lyme
    Staffordshire
    900006930001

    20:20 MOBILE (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    All assets debenture
    Creato il 26 nov 2009
    Consegnato il 08 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All assets of the company by way of a fixed and floating charge.
    Persone aventi diritto
    • Credit Agricole Commercial Finance (Eurofactor UK LTD)
    Transazioni
    • 08 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 04 lug 2008
    Consegnato il 15 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The pledged shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD. in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 lug 2008
    Consegnato il 15 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD. in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 22 nov 2006
    Consegnato il 05 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1,000 shares of a nominal value of eight euros (eur 8) each (together with the shares and/or securities the pledged shares), any shares and/or securities, any income incidentals and any rights resulting from the pledged shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD. in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 05 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession and charge
    Creato il 22 nov 2006
    Consegnato il 05 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mizuho Corporate Bank, LTD. in Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 05 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 feb 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 nov 2005
    Consegnato il 09 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 09 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    20:20 MOBILE (UK) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 dic 2014Inizio della liquidazione
    19 mag 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0