JMP CONSULTING LIMITED
Panoramica
| Nome della società | JMP CONSULTING LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04842439 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di JMP CONSULTING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova JMP CONSULTING LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Dukes Court C/O Systra Limited, 4th Floor Duke Street GU21 5BH Woking Surrey England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di JMP CONSULTING LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| M M & S (3013) LIMITED | 23 lug 2003 | 23 lug 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di JMP CONSULTING LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2015 |
Quali sono le ultime deposizioni per JMP CONSULTING LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da PO Box GU21 5BH 4th Floor Dukes Court 4th Floor Dukes Court Duke Street Woking Surrey GU21 5BH United Kingdom a Dukes Court C/O Systra Limited, 4th Floor Duke Street Woking Surrey GU21 5BH in data 22 feb 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gordon James Baker come amministratore in data 13 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Pascal Mercier come amministratore in data 13 feb 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Peter Beswick come amministratore in data 13 feb 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Daniel Ventham come segretario in data 10 feb 2017 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Evan Roberts come segretario in data 10 feb 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy O'neill come amministratore in data 01 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , 27-32 Old Jewry, London, EC2R 8DQ a PO Box GU21 5BH 4th Floor Dukes Court 4th Floor Dukes Court Duke Street Woking Surrey GU21 5BH in data 16 nov 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr John Evan Roberts come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr John Evan Roberts come segretario in data 18 dic 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Aidan Stuart Eaglestone come amministratore in data 18 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy O'neill come amministratore in data 18 dic 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas Paul Lander come amministratore in data 18 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 lug 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da , Abacus House 33 Gutter Lane, London, EC2V 8AS a PO Box GU21 5BH 4th Floor Dukes Court 4th Floor Dukes Court Duke Street Woking Surrey GU21 5BH in data 27 lug 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 23 lug 2014 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 lug 2014 al 31 dic 2013 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di JMP CONSULTING LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VENTHAM, Daniel | Segretario | C/O Systra Limited, 4th Floor Duke Street GU21 5BH Woking Dukes Court Surrey England | 224394400001 | |||||||
| EAGLESTONE, Aidan Stuart | Amministratore | C/O Systra Limited, 4th Floor Duke Street GU21 5BH Woking Dukes Court Surrey England | United Kingdom | British | 203651150001 | |||||
| MERCIER, Pascal | Amministratore | C/O Systra Limited, 4th Floor Duke Street GU21 5BH Woking Dukes Court Surrey England | United Kingdom | French | 183102500002 | |||||
| BARRETT, Karen Ann | Segretario | 33 Gutter Lane EC2V 8AS London Abacus House England | British | 78889280002 | ||||||
| ROBERTS, John Evan | Segretario | 4th Floor Dukes Court Duke Street Gu21 5bh GU21 5BH Woking 4th Floor Dukes Court Surrey United Kingdom | 213799640001 | |||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Segretario nominato | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| BAKER, Gordon James | Amministratore | 4th Floor Dukes Court Duke Street Gu21 5bh GU21 5BH Woking 4th Floor Dukes Court Surrey United Kingdom | Scotland | British | 95766710002 | |||||
| BARRETT, Karen Ann | Amministratore | 33 Gutter Lane EC2V 8AS London Abacus House England | England | British | 78889280002 | |||||
| BESWICK, Alan Peter | Amministratore | 4th Floor Dukes Court Duke Street Gu21 5bh GU21 5BH Woking 4th Floor Dukes Court Surrey United Kingdom | England | English | 87322160001 | |||||
| CAMERON, Ian Edwin | Amministratore | 98 Harboro Road M33 6GF Sale Cheshire | England | British | 55122110002 | |||||
| GOODEN, David | Amministratore | 2 Spindleberry Close AL6 0SJ Welwyn Hertfordshire | England | British | 67774350002 | |||||
| HOLMES, Graham Neville | Amministratore | 6 Strathearn Avenue Whitton TW2 6JU Twickenham | British | 62414100001 | ||||||
| LANDER, Nicholas Paul | Amministratore | Old Jewry EC2R 8DQ London 27-32 England | England | British | 75197190004 | |||||
| O'NEILL, Timothy | Amministratore | 4th Floor Dukes Court Duke Street Gu21 5bh GU21 5BH Woking 4th Floor Dukes Court Surrey United Kingdom | England | British | 189879660001 | |||||
| OLDHAM, Darren | Amministratore | Blackfriars House Parsonage M3 2JA Manchester | United Kingdom | British | 87322090001 | |||||
| PATERSON, Gordon Weir | Amministratore | 389 Glasgow Road Waterfoot G76 8RN Glasgow Lanarkshire | British | 102112570001 | ||||||
| PETTITT, Richard Noel | Amministratore | 4 The Cricketers Alrewas DE13 7DJ Burton-On-Trent Chardine Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 95468480005 | |||||
| WISHER, Anthony Neil | Amministratore | 105 Maze Hill Greenwich SE10 8XQ London | England | British | 100040920001 | |||||
| VINDEX LIMITED | Amministratore | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 64555080001 | |||||||
| VINDEX SERVICES LIMITED | Amministratore | 151 St Vincent Street G2 5NJ Glasgow | 64555070001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di JMP CONSULTING LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systra Limited | 30 giu 2016 | Duke Street GU21 5BH Woking Dukes Court Surrey England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0