INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04843148 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bridge House Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INNOVISE SOFTWARE AND SOLUTIONS LIMITED | 15 set 2009 | 15 set 2009 |
| TIMEGATE GROUP LIMITED | 23 mar 2004 | 23 mar 2004 |
| TIMEGATE MANAGED SERVICES LIMITED | 23 lug 2003 | 23 lug 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Shona Hemmings come segretario in data 11 set 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 5 pagine | DS01 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 22 ott 2020
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2019 | 13 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr John Leiferman come amministratore in data 16 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Gordon Glenn Macneill come amministratore in data 16 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony John Edwards come segretario in data 16 dic 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Anthony John Edwards come amministratore in data 16 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Ms Shona Hemmings come segretario in data 16 dic 2019 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Modifica dei dettagli di Innovise Limited come persona con controllo significativo il 14 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 17-23 High Street Slough SL1 1DY a Bridge House Waterfront East Level Street Brierley Hill DY5 1XR in data 14 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 gen 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Alan Taylor il 04 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEIFERMAN, John | Amministratore | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | United States | American | 266537730001 | |||||
| MACNEILL, Gordon Glenn | Amministratore | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | United States | American | 259470050001 | |||||
| TAYLOR, Michael Alan | Amministratore | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | England | British | 118715690002 | |||||
| BHARDWAJ, Ashok | Segretario nominato | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | British | 900010640001 | ||||||
| EDWARDS, Anthony John | Segretario | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | British | 127769840001 | ||||||
| HEMMINGS, Shona | Segretario | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | 266447090001 | |||||||
| ONACKO, Andrew Paul | Segretario | Trevelyan Place St. Stephens Hill AL1 2DT St. Albans 9 Hertfordshire | British | 140818600002 | ||||||
| TAYLOR, Michael Alan | Segretario | Pelhams Walk KT10 8QA Esher 37 Surrey | British | 118715690001 | ||||||
| TRIGG, Jason | Segretario | 31 Winchester Close CM23 4JG Bishops Stortford Hertfordshire | British | 65578020001 | ||||||
| TAYLER BRADSHAW LIMITED | Segretario | Cambridge House 16 High Street CB10 1AX Saffron Walden Essex | 146169230001 | |||||||
| DRYBURGH, Robert James | Amministratore | 37 Hermitage Gardens EH10 6AZ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 119904610001 | |||||
| EDWARDS, Anthony John | Amministratore | Waterfront East Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House United Kingdom | United Kingdom | British | 127769840001 | |||||
| MCKENNA, Joseph Robert | Amministratore | 3 Hillside Cumnor Hill OX2 9HS Oxford | Uk | British | 74939700002 | |||||
| ROUND, David William | Amministratore | 12 Lindale Crescent DY5 2RL Brierley Hill West Midlands | United Kingdom | British | 95994170001 | |||||
| TRIGG, Jason | Amministratore | 31 Winchester Close CM23 4JG Bishops Stortford Hertfordshire | British | 65578020001 | ||||||
| BHARDWAJ CORPORATE SERVICES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 47-49 Green Lane HA6 3AE Northwood Middlesex | 900010630001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovise Limited | 06 apr 2016 | Level Street DY5 1XR Brierley Hill Bridge House Waterfront East United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
INNOVISE S & S HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 24 ott 2005 Consegnato il 26 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 mag 2005 Consegnato il 26 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0