SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED

SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSPP (GENERAL PARTNER) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04867229
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Begbies Traynor London 31st Floor 40
    Bank Street
    E14 5NR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    19 pagineLIQ13

    Indirizzo della sede legale modificato da 3 Cadogan Gate London SW1X 0AS England a C/O Begbies Traynor London 31st Floor 40 Bank Street London E14 5NR in data 28 apr 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 14 apr 2021

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ago 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018

    12 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Baker Street London W1U 8EW England a 3 Cadogan Gate London SW1X 0AS in data 05 mar 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di David John Till come amministratore in data 15 feb 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 14 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 30 giu 2017

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 36 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 49 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 47 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 48 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 46 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 43 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 45 in pieno

    10 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 44 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 41 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 42 in pieno

    6 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRUSE, David
    Haygreen Road
    CM8 1FS Witham
    4
    Essex
    England
    Segretario
    Haygreen Road
    CM8 1FS Witham
    4
    Essex
    England
    207954550001
    WOOD, Robert David Surrell
    West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    52
    Surrey
    England
    Amministratore
    West Hill Avenue
    KT19 8JU Epsom
    52
    Surrey
    England
    EnglandBritish49660930003
    KEELER, Robert Michael
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    173987530001
    MACFARLANE, Ian Lennox
    2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    2nd Floor
    West Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    2 City Place
    Beehive Ring Road
    RH6 0PA Gatwick
    2nd Floor
    West Sussex
    United Kingdom
    British36025610002
    STOCKWELL, Fiona Alison
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Segretario
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    183673400001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023580001
    ATKINSON, Nigel Geoffrey
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    EnglandBritish80304150003
    DAVIS, Simon Welland
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish117375860001
    DAVIS, Simon Welland
    8 Henry Tate Mews
    SW16 3HA London
    Amministratore
    8 Henry Tate Mews
    SW16 3HA London
    EnglandBritish117375860001
    FROWEN, Ross Andrew
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish89024010001
    GOULD, Graham Simon
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    EnglandBritish57492060003
    HOMER, Frederick James
    Quakers Rest
    20 Westfield Avenue
    CM1 1SF Chelmsford
    Essex
    Amministratore
    Quakers Rest
    20 Westfield Avenue
    CM1 1SF Chelmsford
    Essex
    British8311710001
    KATTEN, Adam Simon
    50 Tenterden Drive
    NW4 1EE London
    Amministratore
    50 Tenterden Drive
    NW4 1EE London
    EnglandBritish103152720001
    KEELER, Robert Michael
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish2191420002
    NEWMAN, Jeremy Steven
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    Amministratore
    Bdo Stoy Hayward Llp
    8 Baker Street
    W1U 3LL London
    British100600600001
    PHILLIPS, Matthew David
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish163675910001
    PITMAN, David Brian
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish97458840001
    PITTAL, Lee Elliott
    55 Kingwell Road
    EN4 0HZ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Amministratore
    55 Kingwell Road
    EN4 0HZ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish73759660001
    SPILG, Richard
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United Kingdom
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United Kingdom
    United KingdomS African/Australia62769720005
    STILLERMAN, Barry Ian
    7 London Road
    HA7 4PA Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    7 London Road
    HA7 4PA Stanmore
    Middlesex
    British2213810001
    SZPAK, Christopher William
    144 Hall Lane
    RM14 1AT Upminster
    Essex
    Amministratore
    144 Hall Lane
    RM14 1AT Upminster
    Essex
    EnglandBritish55418840002
    THOMPSON, David Harold
    Hurst Gate
    Portsmouth Road
    GU8 5HH Milford
    Surrey
    Amministratore
    Hurst Gate
    Portsmouth Road
    GU8 5HH Milford
    Surrey
    EnglandBritish56157870002
    TILL, David John
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    England
    Amministratore
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    England
    EnglandBritish133593570002
    WALTERS, Robert Martin
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    Amministratore
    Baker Street
    W1U 7EU London
    55
    United KingdomBritish111675130001
    WOLFSON, Andrew Daniel
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    United Kingdom
    Amministratore
    Cadogan Gate
    SW1X 0AS London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish68313170005
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bgm 55 Limited
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    06 apr 2016
    Baker Street
    W1U 8EW London
    55
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land k/a kensington house 136 suffolk street queensway birmingham t/no. WM387080 and l/h land k/a car park kensington house ellis street ellis street birmingham t/no. WM518050 by way of fixed charge all the plant, machinery, implements, utensils, furniture and equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of rental income
    Creato il 25 mag 2010
    Consegnato il 09 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All rental income in f/h land k/a kensington house 136 suffolk street queensway birmingham t/no. WM387080 and l/h land k/a car park kensington house ellis street ellis street birmingham t/no. WM518050 and charges the rent account and all its right, title and interest in the monies from time to time see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 09 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 29 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, fitzwilliam strategic property partnership fund no.3 Limited partnership and spp wombwell limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Right title interest and benefit present or future to all moneys owing or incurred under the leases in respect of the f/h property k/a biggin hill airport trading estate wireless road biggin hill westerham t/nos SGL387008 and SGL563799 other than sums receivable by the company by way of insurance contributions service charges payments to sinking funds or any vat payable thereon including the right to receive the same and the benefit of any guarantee or security for the performance thereof now or at any time hereafter all right title and interest in respect of payment of the rent guarantee. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 29 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 19 mar 2008
    Consegnato il 29 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company, fitzwilliam strategic property partnership fund no.3 Limited partnership and spp wombwell limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H biggin hill airport trading estate wireless road biggin hill westerham t/nos SGL387008 and SGL563799; together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same all monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any).
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance LTD
    Transazioni
    • 29 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge
    Creato il 24 dic 2007
    Consegnato il 09 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledges the shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent for Itself and on Behalf of the Finance Paries
    Transazioni
    • 09 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share pledge agreement
    Creato il 24 dic 2007
    Consegnato il 04 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Euros 5,124,000.00 due or to become due
    Brevi particolari
    All shares in FSPP3 S.A.R.L. registered in the name of the company in its capacity as general partner of fitzwilliam strategic property partnership fund no 3 limited partnership.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 04 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 29 ott 2007
    Consegnato il 03 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being land at 124-182 (evens) park farm drive, allestree, derby t/no. DY273330 and flats 57-99 carsington house, carsington crescent, allestree t/no. DY275741 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale. Assigned to the lender the related rights. Fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery. Floating charge the undertaking all property and assets. Assigned the goodwill and the intellectual property.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 03 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 20 lug 2007
    Consegnato il 27 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company acting in its capacity as general partner for the spp opportunities fund limited partnership (LP 008950) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land severnside trading estate st andrews road avonmouth bristol t/no AV57692 together with all buildings thereon and all fixtures subject to and with the benefit of all rights easements covenants restrictions stipulations agreements declarations and other matters affecting and/or benefiting the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 27 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 37-39 oxford street, st anne, westminster t/n 163574 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 19 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land being unit 3A holloway drive worsley t/n GM907985, and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 19 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental deed
    Creato il 03 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from spp income fund limited spp (general partner) limited spp wombwell limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a kensington house suffolk street queensway birmingham t/no WM387080 and l/h property k/a car park kensington house ellis street queensway birmingham t/no WM518050 including all buildings. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment
    Creato il 03 ott 2006
    Consegnato il 11 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from spp (general partner) limited spp wombwell limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgages (General) LTD
    Transazioni
    • 11 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge deed
    Creato il 18 ago 2006
    Consegnato il 23 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    The principal sum and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being grice's granary rotherhide street london and st mary's warehouse st mary church street london t/nos sgl 206477 and ln 155413 all fixtures and by way of specific charge all the income from time to time arising or payable to or on behalf of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 23 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 20 lug 2006
    Consegnato il 25 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    16 to 28 (even numbers) high street and 40 to 44 regent street, weston-super-mare t/no AV229667 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 25 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of rental assignment
    Creato il 01 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from spp income fund LP acting by its general partner spp (general partner) limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Assigns the rent. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a unit 107 tenth avenue deeside industrial estate deeside flintshire. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 01 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Lh property k/a 107 tenth avenue deeside industrial estate deeside flintshire. Together with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery thereon the goodwill of any business carried on at the property the benefit of any licences and registrations required in the running of such business. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 01 ago 2005
    Consegnato il 10 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nationwide Building Society
    Transazioni
    • 10 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Target house gatehouse road aylesbury t/n BM145034 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Templar house ashford t/n K157842 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Kent house 81 station road ashford and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Park farm centre allestree derby, f/h land lying to the other of birchover way t/n DY13410, f/h land being park farm centre birchover way t/n DY170858 and the park farm hotel park farm centre park farm t/n DY1900798 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land and buildings on the west side of poole hall road ellesmere port t/n CH195401 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 30 apr 2005
    Consegnato il 07 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H units 1-26 cochran close, crown hill, milton keynes t/n BM166901 and all its fixtures and by way of specific charge all the income in relation to the property and the proceeds of sale.assigned to the lender the related rights.fixed charge the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual PROPERTY09.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 07 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge deed
    Creato il 08 apr 2005
    Consegnato il 14 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land being 44 and 44A worship street hackney london t/no ngl 315350 the equipment and goods and all fixtures fittings fixed plant and machinery.floating charge the undertaking all property and assets.assigned the goodwill and the intellectual property.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Rock PLC
    Transazioni
    • 14 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    SPP (GENERAL PARTNER) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    14 apr 2021Inizio della liquidazione
    21 lug 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary Paul Shankland
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor, 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Irvin Milton Cohen
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Praticante
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0