AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED

AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04895923
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AVERY WEIGH-TRONIX NO. 1 LIMITED11 set 200311 set 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    21 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 13 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    23 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Transitional provisions and savings 05/06/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 giu 2019

    • Capitale: GBP 8,682,075
    4 pagineSH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Nomina di Ryan Ronald Dale come segretario in data 18 dic 2017

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Philip Matthew Deakin come amministratore in data 30 ott 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen James Rowell il 12 ott 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Edward Ufland come amministratore in data 13 mar 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Nomina di Stephen James Rowell come amministratore in data 01 apr 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    22 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DALE, Ryan Ronald
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    Segretario
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    241474930001
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Segretario
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione01740543
    132600000001
    HUDSON, Giles Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish161583790003
    ROWELL, Stephen James
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    United KingdomBritish208316380001
    FOGARTY, Robert Joseph
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    Segretario
    April Cottage Manor Lane
    Little Comberton
    WR10 3ER Pershore
    Worcestershire
    British17437720002
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Segretario
    Carmelite
    50 Victoria Embankment Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    84071220001
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    Uk
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    BOWE, Gerald Grant
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    Amministratore
    85 Pasquaney Lane
    Bridgewater
    Nh 03222
    Usa
    American86912720003
    CRAMER, Carl, Mr.
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    Amministratore
    2 Little Dormers
    South Park Crescent
    SL9 8HJ Gerrards Cross
    United KingdomBritish92710960001
    DEAKIN, Philip Matthew
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    United KingdomBritish146225080003
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    Amministratore
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UFLAND, Edward
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    Amministratore
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    EnglandBritish161583570001
    HUNTSMOOR LIMITED
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    Amministratore
    Carmelite 50 Victoria Embankment
    Blackfriars
    EC4Y 0DX London
    39090660001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    Amministratore
    Carmelite
    50 Victoria Embankment
    EC4Y 0DX Blackfriars
    London
    41864110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    A V Co 3 Limited
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    06 apr 2016
    Aldermanbury Square
    13th Floor
    EC2V 7HR London
    5
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleCompanies Act 1985
    Luogo di registrazioneCompanies House, Uk
    Numero di registrazione5851993
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    AVERY WEIGH-TRONIX HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • European Capital Financial Services Limited (As Security Agent for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Collateral agreement
    Creato il 31 lug 2006
    Consegnato il 18 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each present and future member of the group (or any of them) to the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All capital stock and investment property and all products and proceeds, accessions, stock rights, stock dividends, liquidating dividends, new securities, payments, distributions and proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • European Capital Financial Services Limites as Security Agent for the Finance Parties (The"Security Agent")
    Transazioni
    • 18 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 10 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the shares,all related rights.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Keyman insurance assignment
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 17 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them and to the security trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Life assured gerald bowe,sum assured $1,000,000,termination date 27TH september 2048,assurance society protective insurance company,policy number and description life PLO784438 (for further details of life assured see form 395) to assign absolutely its interest in and to the policies and the proceeds and the full benefit thereof as a continuing security to the security trustee.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 17 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ago 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 01 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the holdings or any of its subsidiaries to an agent or to any lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fleet National Bank
    Transazioni
    • 01 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 dic 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0