EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED

EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04913180
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagine4.72

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement liquidator
    10 pagineLIQ MISC OC

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    5 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 15 gen 2013

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da 18 Buckingham Gate London SW1E 6LB in data 21 dic 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 26 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 ott 2012

    Stato del capitale al 08 ott 2012

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 set 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Nomina di Mr Nigel Howard Pope come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stephen Corner come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Nicola Louise Lenthall come segretario

    1 pagineAP03

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 set 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 25 mar 2010 al 31 mar 2010

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Russell Taylor come amministratore

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 26 set 2009 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LENTHALL, Nicola Louise
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    158006330001
    POPE, Nigel Howard
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    Amministratore
    Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish29583660002
    TAYLOR, Peter
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Seymour House
    High Street
    GL55 6AG Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish109810150001
    CORNER, Stephen Donald
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    Segretario
    57 Mayfield Avenue
    BR6 0AJ Orpington
    Kent
    British85743480001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    TAYLOR, Russell John
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Church Road
    NE9 5XE Gateshead
    123
    Tyne And Wear
    EnglandBritish79902420003

    EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 23 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property site number BT76/77 nelson park industrial estate northumberland,. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 19 ott 2007
    Consegnato il 20 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property k/a site BT76/77 nelson park industrial estate cramlington any insurances, all gross rents. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 17 nov 2006
    Consegnato il 21 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 12 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a BT76/73 nelson way, cramlington, northumberland with all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 12 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 09 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 31 mar 2005
    Consegnato il 09 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    L/H site no. Bt 76/73 nelson park industrial estate cramlington northumberland. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over construction contract
    Creato il 13 set 2004
    Consegnato il 23 set 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any person who is a party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future rights title and interest in the construction contract and all sums under the building contract.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 23 set 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over funding agreement
    Creato il 18 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's right title and interest to and in and the full benefit of the funding agreement dated 23 april 2004 made between one northeast (1) the company (2) and easter holdings limited (3) relating to the provision of finance for the development to be carried out at site BT76/73 nelson park industrial estate, cramlington, northumberland and all rights and benefits whatsoever in respect of amounts receivable accruing to the company under the funding agreement including all claims for damages in respect of any breach of the funding agreement by any party other than the company.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over building agreement
    Creato il 18 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Building agreement dated 23 april 2004 made between one northeast (1) the company (2) and easter holdings limited (3) relating to site BT76/73 nelson park industrial estate, cramlington, northumberland and the benefit of all the premises comprised thereon and all buldings for the time being erected thereon and the company's estate and interest therein and by way of assignment all monies due or owing to the company under or by virtue of the building agreement.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 dic 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 18 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Floating charge all the undertaking and assets of the company, both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Dunbar Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 dic 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    EASTER PROPERTIES (NELSON WAY) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    15 gen 2013Inizio della liquidazione
    17 apr 2014Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    David John Crawshaw
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    Kpmg Llp 8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Robert Andrew Croxen
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Jane Bronwen Moriarty
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0