CARE UK HEALTHCARE LIMITED

CARE UK HEALTHCARE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE UK HEALTHCARE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04919664
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MERCURY HEALTH LIMITED25 nov 200325 nov 2003
    OVAL (1899) LIMITED02 ott 200302 ott 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Mark Atkinson Hunt come amministratore in data 11 lug 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    12 pagineAA

    Nomina di Jonathan David Calow come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Care Uk Services Limited come segretario in data 08 dic 2011

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 ott 2011

    Stato del capitale al 06 ott 2011

    • Capitale: GBP 1,000,001
    SH01

    Nomina di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Deans come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    28 pagineMG01

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010

    2 pagineCH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    12 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    11 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Ian Deans come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Dr Mark Hunt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Care Uk Secretaries Ltd come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 02 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Secretaries Ltd il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Limited il 01 ott 2009

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALOW, Jonathan David
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Segretario
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    165449350001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Amministratore
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    United KingdomBritishFinance Director33223550003
    PARISH, Michael Robert
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Amministratore
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    EnglandBritishDirector78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Amministratore
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    EnglandBritishChartered Accountant151240810001
    COLLINS, Richard Hawke
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    5 Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    Gloucestershire
    British53398040001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    BritishDirector33223550003
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Segretario
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector68807890004
    CARE UK SECRETARIES LTD
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125241530001
    CARE UK SERVICES LIMITED
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2482660
    125332040002
    OVALSEC LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Segretario nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002570001
    AICHROTH, Mark Jonathan Paul
    Bridge Farm
    West Lydford
    TA11 7DG Somerton
    Somerset
    Amministratore
    Bridge Farm
    West Lydford
    TA11 7DG Somerton
    Somerset
    BritishHealthcare Executive93633880001
    BREACH, Stephen Derrick
    1 St Helens Avenue
    OX10 6RY Benson
    Oxfordshire
    Amministratore
    1 St Helens Avenue
    OX10 6RY Benson
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director147928530001
    DEANS, Ian David
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Amministratore
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    United KingdomBritishCompany Director133139220001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    Hall Barn Creeting Hall Farm
    Creeting Saint Peter
    IP6 8QZ Ipswich
    Suffolk
    United KingdomBritishDirector33223550003
    HUNT, Mark Atkinson, Dr
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    Amministratore
    Connaught House, 850 The
    Crescent, Colchester Business
    CO4 9QB Park, Colchester
    EnglandBritishCompany Director129906070001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Long Ash
    Woodbridge Lane Withington
    GL54 4BP Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishDirector68807890004
    MARTIN, Peter John
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wangrove
    Berkshire
    Amministratore
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wangrove
    Berkshire
    EnglandBritishDirector176044430001
    MCMILLAN, Jeanette Russell
    Schiehallion
    Featherbed Lane
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Schiehallion
    Featherbed Lane
    CV37 0ER Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishClinical Services Director101495410001
    PITMAN, Henry John
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Pinbury Park
    Duntisbourne Rouse
    GL7 7LG Cirencester
    Gloucestershire
    United KingdomBritishDirector55231490005
    SMITH, Mark Robert
    Flat 36
    23 Hill Lane
    SO15 5PA Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    Flat 36
    23 Hill Lane
    SO15 5PA Southampton
    Hampshire
    BritishDirector101494660001
    OVAL NOMINEES LIMITED
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    Amministratore delegato nominato
    2 Temple Back East
    Temple Quay
    BS1 6EG Bristol
    900002560001

    CARE UK HEALTHCARE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security accession deed
    Creato il 16 set 2010
    Consegnato il 23 set 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank Nv, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 23 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed of accession
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities due or to become due from each company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,as Security Trustee for Itself and the Financeparties
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An assignment of contracts
    Creato il 09 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefits and interests in and to and under each of the assigned contracts including all debts and claims and all rights against third parties in respect of the assigned contracts. The assigned contracts being the subordinated loan agreement and the subordinated debenture and any one of them. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Finance Parties (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 giu 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0