CARE UK HEALTHCARE LIMITED
Panoramica
Nome della società | CARE UK HEALTHCARE LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04919664 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
MERCURY HEALTH LIMITED | 25 nov 2003 | 25 nov 2003 |
OVAL (1899) LIMITED | 02 ott 2003 | 02 ott 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2011 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Atkinson Hunt come amministratore in data 11 lug 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2011 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Jonathan David Calow come segretario in data 08 dic 2011 | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Care Uk Services Limited come segretario in data 08 dic 2011 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ian Deans come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 11 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ott 2010 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 28 pagine | MG01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 10 ago 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 12 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2009 | 11 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG02 | ||||||||||
Nomina di Ian Deans come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Dr Mark Hunt come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Care Uk Secretaries Ltd come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ott 2009 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Secretaries Ltd il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Care Uk Services Limited il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Michael Robert Parish il 01 ott 2009 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARE UK HEALTHCARE LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALOW, Jonathan David | Segretario | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | 165449350001 | |||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | United Kingdom | British | Finance Director | 33223550003 | ||||||||
PARISH, Michael Robert | Amministratore | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | England | British | Director | 78828750003 | ||||||||
PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | England | British | Chartered Accountant | 151240810001 | ||||||||
COLLINS, Richard Hawke | Segretario | 5 Halland Road GL53 0DJ Cheltenham Gloucestershire | British | 53398040001 | ||||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Segretario | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | British | Director | 33223550003 | |||||||||
LAWTON, Simon Marcus | Segretario | Long Ash Woodbridge Lane Withington GL54 4BP Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 68807890004 | |||||||||
CARE UK SECRETARIES LTD | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125241530001 | ||||||||||
CARE UK SERVICES LIMITED | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom |
| 125332040002 | ||||||||||
OVALSEC LIMITED | Segretario nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002570001 | |||||||||||
AICHROTH, Mark Jonathan Paul | Amministratore | Bridge Farm West Lydford TA11 7DG Somerton Somerset | British | Healthcare Executive | 93633880001 | |||||||||
BREACH, Stephen Derrick | Amministratore | 1 St Helens Avenue OX10 6RY Benson Oxfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 147928530001 | ||||||||
DEANS, Ian David | Amministratore | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | United Kingdom | British | Company Director | 133139220001 | ||||||||
HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | Hall Barn Creeting Hall Farm Creeting Saint Peter IP6 8QZ Ipswich Suffolk | United Kingdom | British | Director | 33223550003 | ||||||||
HUNT, Mark Atkinson, Dr | Amministratore | Connaught House, 850 The Crescent, Colchester Business CO4 9QB Park, Colchester | England | British | Company Director | 129906070001 | ||||||||
LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | Long Ash Woodbridge Lane Withington GL54 4BP Cheltenham Gloucestershire | England | British | Director | 68807890004 | ||||||||
MARTIN, Peter John | Amministratore | Vine Cottage 48 High Street RG10 8BY Wangrove Berkshire | England | British | Director | 176044430001 | ||||||||
MCMILLAN, Jeanette Russell | Amministratore | Schiehallion Featherbed Lane CV37 0ER Stratford Upon Avon Warwickshire | British | Clinical Services Director | 101495410001 | |||||||||
PITMAN, Henry John | Amministratore | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | Director | 55231490005 | ||||||||
SMITH, Mark Robert | Amministratore | Flat 36 23 Hill Lane SO15 5PA Southampton Hampshire | British | Director | 101494660001 | |||||||||
OVAL NOMINEES LIMITED | Amministratore delegato nominato | 2 Temple Back East Temple Quay BS1 6EG Bristol | 900002560001 |
CARE UK HEALTHCARE LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security accession deed | Creato il 16 set 2010 Consegnato il 23 set 2010 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of accession | Creato il 09 dic 2004 Consegnato il 29 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All obligations and liabilities due or to become due from each company to the chargee and the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
An assignment of contracts | Creato il 09 dic 2004 Consegnato il 22 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title benefits and interests in and to and under each of the assigned contracts including all debts and claims and all rights against third parties in respect of the assigned contracts. The assigned contracts being the subordinated loan agreement and the subordinated debenture and any one of them. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0