UPMINSTER PROPERTIES LIMITED

UPMINSTER PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàUPMINSTER PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04927611
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Coopers House 65a Wingletye Lane
    RM11 3AT Hornchurch
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 28 feb 2021

    10 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ott 2020 al 28 feb 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2019

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 ott 2017

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2016

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 20 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 ott 2015

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 16 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Terence George Martin il 04 gen 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 09 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 dic 2015

    Stato del capitale al 15 dic 2015

    • Capitale: GBP 4.0002
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Antony Blake Martin il 09 ott 2015

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Antony Blake
    Beggar Hill
    Fryerning
    CM4 0PG Ingatestone
    Lavender Cottage
    Essex
    England
    Segretario
    Beggar Hill
    Fryerning
    CM4 0PG Ingatestone
    Lavender Cottage
    Essex
    England
    BritishRetired108615090001
    MARTIN, Anthony Blake
    Beggar Hill
    Fryerning
    CM4 0PG Ingatestone
    Lavender Cottage
    Essex
    England
    Amministratore
    Beggar Hill
    Fryerning
    CM4 0PG Ingatestone
    Lavender Cottage
    Essex
    England
    United KingdomBritishRetired93309320002
    MARTIN, Terence George
    Stock Road
    CM12 0BE Billericay
    38
    Essex
    England
    Amministratore
    Stock Road
    CM12 0BE Billericay
    38
    Essex
    England
    United KingdomBritishRetired93309840003
    RICHES, Teresa Jane
    20 Engayne Gardens
    RM14 1UZ Upminster
    Essex
    Amministratore
    20 Engayne Gardens
    RM14 1UZ Upminster
    Essex
    United KingdomBritishTeacher93309780001
    O'GORMAN, John Spencer
    30 Ridgemont Place
    RM11 3LQ Hornchurch
    Essex
    Segretario
    30 Ridgemont Place
    RM11 3LQ Hornchurch
    Essex
    BritishIt Consultant86536520001
    TEMPLE SECRETARIES LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Segretario nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001120001
    O'GORMAN, John Spencer
    30 Ridgemont Place
    RM11 3LQ Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    30 Ridgemont Place
    RM11 3LQ Hornchurch
    Essex
    BritishIt Consultant86536520001
    COMPANY DIRECTORS LIMITED
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    Amministratore delegato nominato
    788-790 Finchley Road
    NW11 7TJ London
    900001110001

    Chi sono le persone con controllo significativo di UPMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Terence George Martin
    CM12 0BE Billericay
    38 Stock Road
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    CM12 0BE Billericay
    38 Stock Road
    Essex
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mrs Teresa Jane Riches
    CM12 0BE Billericay
    38 Stock Road
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    CM12 0BE Billericay
    38 Stock Road
    Essex
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Anthony Blake Martin
    Beggar Hill
    CM4 0PG Fryerning
    Lavender Cottage
    Essex
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Beggar Hill
    CM4 0PG Fryerning
    Lavender Cottage
    Essex
    United Kingdom
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: United Kingdom
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    UPMINSTER PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18 coach road great horkesley colchester essex t/no EX716386 by way of first fixed charge all proceeds of any insurance's, the goodwill of any business. By way of equitable assignment all the borrowers rights title and interest in the benefit of all guarantees warranties and representations given or made now or hereafter. By way of mortgage the benefit of the landlord to and in the occupation leases and the rents. By way of assignment the policy.
    Persone aventi diritto
    • The Mortgage Works (UK) PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 28 nov 2007
    In corso
    Importo garantito
    £211,200.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    11 stilemans wood cressing braintree essex CM77 8GR.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 28 feb 2007
    Consegnato il 06 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    18 hubert road rainham essex.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 06 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 16 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    18 coach road great horkesley colchester essex. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    £56,087.50 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    12 marion street sunderland tyne & wear and all that f/h interest in the property k/a 11 marion street sunderland tyne & wear.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 gen 2007
    Consegnato il 11 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    £56,087.50 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    11 marion street sunderland tyne & wear and all that f/h interest in the property k/a 12 marion street sunderland tyne & wear.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 giu 2006
    Consegnato il 14 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    £55,884.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    F/H property k/a 16 derby street hartlepool cleveland t/no CE152906.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 14 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 08 giu 2006
    Consegnato il 16 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    £55,250.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    51 tower street west hendon sunderland t/no TY223718.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 2006
    Consegnato il 30 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    £55,899.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    F/H property k/a 9 drayton road liverpool t/no MS249586.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 30 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £47,267.50 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    F/H property k/a 10 strangways street seahamco durham t/no DU126399.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 14 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    £51,000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    The f/h property known as 45 arthur street windlestone ferryhill t/n DU192809.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 14 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 11 feb 2005
    Consegnato il 16 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    23 market street seaham county curham SR7 7R9.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 16 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 feb 2005
    Consegnato il 17 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    An initial advance of £35,928.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee upon any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    4 odette street gorton greater manchester.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 17 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 27 gen 2005
    Consegnato il 05 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    £56,517.94 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    72 caroline street, hetton le hole tyne & wear sunderland.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 05 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 24 gen 2005
    Consegnato il 04 feb 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    79 albert street grange villa chester le street durham.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Trust Limited
    Transazioni
    • 04 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 14 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    11 marion street sunderland t/no: TY207427. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 29 nov 2004
    Consegnato il 16 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property k/a 12 marion street, sunderland. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 26 nov 2004
    Consegnato il 14 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45 arthur street windlestone chilton DL17 0PZ. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 07 mag 2004
    Consegnato il 19 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £38,250.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    9 drayton road liverpool.
    Persone aventi diritto
    • Paragon Mortgages Limited
    Transazioni
    • 19 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 lug 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0