PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPREFERRED FUNDING FIVE LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04930708
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hays Galleria
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINKCLOSE LIMITED14 ott 200314 ott 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 set 2018

    7 pagineLIQ03

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 04 set 2017

    LRESSP

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagineLIQ01

    Dichiarazione di conformità presentata il 27 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom a Hays Galleria 1 Hays Lane London SE1 2rd in data 13 apr 2017

    2 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    6 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 nov 2015

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2016

    Stato del capitale al 15 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 23 25 Canada Square London E14 5LQ a 10-18 Union Street London SE1 1SZ in data 22 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 30 nov 2014

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 giu 2015

    Stato del capitale al 15 giu 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2013

    17 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 giu 2014

    Stato del capitale al 03 giu 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 30 nov 2012

    16 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    11 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Other company business 08/03/2013
    RES13

    Bilancio annuale redatto al 27 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 nov 2011

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BRANDON, Lee Christopher
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    Amministratore
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United KingdomBritish152212570001
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Segretario
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES (CCA) LIMITED
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    Segretario
    Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    10
    83911920002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    38508390004
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TMF CORPORATE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Segretario
    1st Floor, 9 Cloak Lane
    EC4R 2RU London
    Pellipar House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06902863
    140723560001
    ATTIA, Amany
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    Amministratore
    Girdlers Road
    W13 0PU London
    8
    United KingdomFrench - American94699620002
    ATTIA, Amany
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    Amministratore
    The Old House
    W6 7BD 101 Brook Green
    London
    French American94699620001
    BILSBOROUGH, William C
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Amministratore
    Tresanton
    Hancocks Mount
    SL5 9PQ Sunninghill
    Berkshire
    Us Citizen107220450001
    CHAMBERS, Paul Stuart
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    Amministratore
    Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    10
    Kent
    United KingdomBritish172496620001
    FRASER, George Mclennan
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Amministratore
    57 Chipstead Street
    SW6 3SR London
    Australian94699810001
    GIBB, Dominic Iain
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    Amministratore
    2 Falkland Place
    NW5 2PN London
    British62250460004
    HINSHELWOOD, Wallace Simon Duthie
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Amministratore
    11 Wheelwrights Close
    CM23 4GH Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish91642420002
    HOPES, Philip Edward
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    Amministratore
    Ellensdaw
    Polecat Lane
    RH13 6QR Copsale
    West Sussex
    British59370220003
    INGRAM, Nigel Jeffrey Martin
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    Amministratore
    Meadowlands
    Winterpit Lane
    RH13 6LZ Mannings Heath
    West Sussex
    United KingdomBritish97379760001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MEHR, Amir
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Hartwell Drive
    HP9 1JA Beaconsfield
    5
    Buckinghamshire
    United KingdomAmerican130034860001
    PATELLIS, George
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Gatehouse
    20 Kings Gate
    RH16 1DY Haywards Heath
    West Sussex
    United KingdomAmerican76275030002
    PITOCCO, Dennis James
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    The Annexe Cedar Lodge
    6 Calbourne
    RH16 4AQ Haywards Heath
    West Sussex
    American59515170003
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Amministratore
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritish162620820001
    RUPP, Christopher Gordon
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Revelmead
    Hillside Road
    TN13 3XJ Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritish72545640001
    STAID, Stephen
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    1 Ridgeway
    GU25 4TE Virginia Water
    Surrey
    United KingdomAmerican125380160001
    TAYLOR, Roger John
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    Amministratore
    Rare Oak
    Highfield Gardens
    GU33 7NQ Liss
    Hampshire
    British68131560002
    WEIR, Louise Jane
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    Amministratore
    Tunnel Lane
    North Warnborough
    RG29 1JT Hook
    Heron House
    Hants
    EnglandBritish130033570001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    06 apr 2016
    1 Hays Lane
    SE1 2RD London
    Hays Galleria
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUnited Kingdom (Uk)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03137809
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A warehouse deed of charge
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 28 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affilliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title interest and benefit present and future in the secur ity assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited
    Transazioni
    • 28 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An amended and restated deed relating to a warehouse deed of charge dated 27 july 2005 and
    Creato il 09 nov 2005
    Consegnato il 23 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right title interest and benefit, present and future, in the security assets, the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties,Including Itself)
    Transazioni
    • 23 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation in security
    Creato il 25 ott 2005
    Consegnato il 27 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's whole right title and interest in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited Acting as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 27 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Creato il 25 ott 2005
    Consegnato il 26 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties or their respective affiliates or to any receiver on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title, interest and benefit, present and future in the security assets the benefit of the collateral security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited Acting as Security Truatee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 26 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 06 ago 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 gen 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 31 gen 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental assignation in security
    Creato il 28 lug 2005
    Consegnato il 17 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any of all of the secured parties or to any receiver under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All principal sums and further advances all of scotish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited (The Secutrity Trustee)
    Transazioni
    • 17 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A warehouse deed of charge
    Creato il 27 lug 2005
    Consegnato il 16 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Storm Funding Limited (Holding the Benefit of the Security on Trust for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 16 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 16 gen 2006Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 30 mag 2008Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 03 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation in security
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 03 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or preferred mortgages limited to any or all of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The whole right, title and interest, present and future, in and to the scottish mortgage trust property and in and to the scottish declaration of trust.
    Persone aventi diritto
    • Mable Commercial Funding Limited in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 03 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Warehouse deed of charge
    Creato il 05 nov 2003
    Consegnato il 14 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or the guarantor to any or all of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all its right title interest and benefit in the security assets including the english mortgage loans and northern irish mortgage loans, the right to demand sue for recover receive and give receipts for all principal moneys payable or to become payable under the english mortgage loans or the northern irish mortgage loans. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mable Commercial Funding Limited as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transazioni
    • 14 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 apr 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    PREFERRED FUNDING FIVE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 set 2017Inizio della liquidazione
    08 feb 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0