REVENET SOLUTIONS LIMITED
Panoramica
Nome della società | REVENET SOLUTIONS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04939176 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di REVENET SOLUTIONS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Suite 1, 3rd Floor 11-12 St. James's Square SW1Y 4LB London United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
UKB SOLUTIONS LIMITED | 05 lug 2011 | 05 lug 2011 |
802 GLOBAL LIMITED | 06 set 2010 | 06 set 2010 |
802 LIMITED | 21 ott 2003 | 21 ott 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jordan Cosec Limited il 05 apr 2019 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Notifica di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo | 2 pagine | PSC08 | ||||||||||
Cessazione di Uk Broadband Limited come persona con controllo significativo il 09 mag 2017 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Martin O'donnell come amministratore in data 27 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas James Williams come amministratore in data 27 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ms Christina Tsz Wan Lui come amministratore in data 26 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Robert Ford come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jordan Cosec Limited il 16 ago 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 20-22 Bedford Row London WC1R 4JS a Suite 1, 3rd Floor 11-12 st. James's Square London SW1Y 4LB in data 02 ago 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 ott 2016 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas James Williams il 30 ago 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VISTRA COSEC LIMITED | Segretario | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
| 128256230002 | ||||||||||
LUI, Christina Tsz Wan | Amministratore | Taikoo Place 979 King's Road Quarry Bay 41st Floor, Pccw Tower Hong Kong | Hong Kong | Chinese | Company Director | 237644370002 | ||||||||
O'DONNELL, Martin | Amministratore | 6th Floor Exchequer Court 33 St Mary Axe EC3A 8AA London C/O Pccw Global Limited United Kingdom | United Kingdom | Irish | None Supplied | 238392810001 | ||||||||
CLOSE, Timothy Maurice | Segretario | Pavilion Cottage Eastfield Lane RG8 7EJ Whitchurch On Thames Berkshire | Australian | Sales Director | 85047960001 | |||||||||
SHAW-HARDIE, Nicholas David | Segretario | 9 Fairmount Shalbourne SN8 3QJ Marlborough Wiltshire | British | Accountant | 30092760001 | |||||||||
BTC (SECRETARIES) LIMITED | Segretario nominato | Btc House Chapel Hill PR3 3JY Longridge Preston Lancashire | 900024210001 | |||||||||||
CLOSE, Timothy Maurice | Amministratore | Pavilion Cottage Eastfield Lane RG8 7EJ Whitchurch On Thames Berkshire | England | Australian | Sales Director | 85047960001 | ||||||||
FORD, David Robert, Sir | Amministratore | Bedford Row WC1R 4JS London 20-22 | United Kingdom | British | Director | 88899120005 | ||||||||
SHAW HARDIE, Nicholas David | Amministratore | Fairmount Shalbourne SN8 3QJ Marlborough 9 Wiltshire | British | Finance Director | 133659500001 | |||||||||
SOMERVILLE, Andrew Neil | Amministratore | Aldbourne Road Burnham SL1 7NJ Slough 27 Berkshire | United Kingdom | British | Chief Technology Officer | 133659830001 | ||||||||
VINCENT, Timothy James | Amministratore | 2 Yew Tree Cottage Elm Road HP10 8LQ Penn Buckinghamshire | England | British | Managing Director | 57341030004 | ||||||||
WILLIAMS, Nicholas James | Amministratore | 236 Gray's Inn Road WC1X 8HB London 5th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Executive | 150521840004 | ||||||||
BTC (DIRECTORS) LTD | Amministratore delegato nominato | Btc House Chapel Hill PR3 3JY Longridge Preston Lancashire | 900024200001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uk Broadband Limited | 06 apr 2016 | WC1R 4JS London 20-22 Bedford Row | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per REVENET SOLUTIONS LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
09 mag 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
REVENET SOLUTIONS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
All assets debenture | Creato il 30 nov 2006 Consegnato il 12 dic 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
All assets debenture | Creato il 23 feb 2006 Consegnato il 24 feb 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All assets of the company by way of a first fixed charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 ago 2004 Consegnato il 14 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite all assets guarantee and debenture | Creato il 22 gen 2004 Consegnato il 29 gen 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0