WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED

WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaConvertita o chiusa
    Numero di società 04948519
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    • Locazione e gestione di immobili di società di edilizia residenziale (68201) / Attività immobiliari

    Dove si trova WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WAKEFIELD & DISTRICT HOUSING LIMITED30 ott 200330 ott 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2017
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2017
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Varie

    Forms b and z convert to rs
    2 pagineMISC

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Convert to rs 23/02/2017
    RES13

    Iscrizione dell'ipoteca 049485190003, creata il 29 mar 2017

    28 pagineMR01
    Note
    DataNota
    03 apr 2017Other The certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which are in colour and/or larger than A4. At present, Companies House does not provide colour or larger images through our output services; therefore some elements may be illegible. If you would like to view a copy of the instrument, please call 02920 381367.

    Cessazione della carica di Ann Cuthbert come amministratore in data 01 mar 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Robert Edward Adams come amministratore in data 01 mar 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2016

    111 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 ott 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Nomina di Mrs Jacqueline Elizabeth Speight come amministratore in data 02 nov 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Graham Stokes come amministratore in data 15 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Nigel Edward Bailey come amministratore in data 15 set 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Miss Sally Wright come amministratore in data 03 dic 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Elaine Rank come amministratore in data 07 mar 2016

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    26 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Kenneth Andrew Wright come amministratore in data 10 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jack Spencer Hemingway come amministratore in data 10 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Denise Margaret Jeffery come amministratore in data 10 set 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    87 pagineAA

    Nomina di Mr Peter Alan Loosemore come amministratore in data 26 feb 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Spedding come amministratore in data 05 gen 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mrs Juliet Marie Craven come segretario in data 01 dic 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Lee Jonathan Sugden come segretario in data 30 nov 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    9 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2014

    86 pagineAA

    Nomina di Mr Jack Spencer Hemingway come amministratore in data 25 set 2014

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAVEN, Juliet Marie
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Segretario
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    193352490001
    ADAMS, Robert Edward
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish86813840005
    CLIFT MBE, William
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish174584770001
    GREEN, Stephen James
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish173051600001
    HARNESS, Kathryn Elizabeth
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish187774630001
    LOOSEMORE, Peter Alan
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish125700210001
    SPEIGHT, Jacqueline Elizabeth
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish200478710001
    STOKES, Graham
    Elizabeth Drive
    WF11 8PD Knottingley
    4
    England
    Amministratore
    Elizabeth Drive
    WF11 8PD Knottingley
    4
    England
    EnglandEnglish49240220001
    WILLIAMS, Jacqueline Ann
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    United KingdomBritish154930420001
    WRIGHT, Sally
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Merefield House
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    Merefield House
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish205928810001
    SUGDEN, Lee Jonathan
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Segretario
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    British123410780003
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Segretario
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    ADAMSON, Colleen
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish100440760002
    ANDERSON, John Goodridge
    50 Shepley Street
    Eastmoor Estate
    WF1 4QW Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    50 Shepley Street
    Eastmoor Estate
    WF1 4QW Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish156213270001
    BAILEY, David Nigel Edward
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish179585190001
    BEILEY, Robert James
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    Amministratore
    30 Keeling House
    Claredale Street
    E2 6PG London
    British85927990001
    BINNERSLEY, Kay, Cllr
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish132281610001
    COOPER, Derek
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish100442930001
    COTTON, Christopher
    12 Cow Lane
    Havercroft
    WF4 2BE Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Cow Lane
    Havercroft
    WF4 2BE Wakefield
    West Yorkshire
    British100440420001
    CUTHBERT, Ann
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish170178680001
    ELLIS, Harry
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    United KingdomBritish161872210001
    FAULL, Margaret Lindsay, Dr
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish42608960001
    HALLIDAY, Ronald William Arthur
    138 Linton Road
    East Moor
    WF1 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    138 Linton Road
    East Moor
    WF1 4HT Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritish108960510001
    HEMINGWAY, Jack Spencer
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish180131650001
    HOLMES, Brian
    20 Tyndale Avenue
    Benton Park Horbury
    WF4 5QT Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    20 Tyndale Avenue
    Benton Park Horbury
    WF4 5QT Wakefield
    West Yorkshire
    British109664610001
    ISHERWOOD, Graham Leslie
    35 Ravensmead Pwston
    Featherstone
    WF7 5AQ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    35 Ravensmead Pwston
    Featherstone
    WF7 5AQ Pontefract
    West Yorkshire
    British100440520001
    JEFFERY, Denise Margaret, Councillor
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish65731200002
    KENDALL, Francis
    37 Priory Close
    Altofts
    WF6 2PT Normanton
    West Yorkshire
    Amministratore
    37 Priory Close
    Altofts
    WF6 2PT Normanton
    West Yorkshire
    British100440400001
    KERSHAW, Jack
    17 Rowan Green
    WF8 2DZ Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    17 Rowan Green
    WF8 2DZ Pontefract
    West Yorkshire
    British43660270001
    NICHOLSON, James
    38 Highfield Road
    WF8 4LL Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    38 Highfield Road
    WF8 4LL Pontefract
    West Yorkshire
    British48457960001
    PAUL, Sarah Jane
    11 Lankester Square
    RH8 0LJ Oxted
    Surrey
    Amministratore
    11 Lankester Square
    RH8 0LJ Oxted
    Surrey
    British102369880001
    RANK, Elaine
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish116278810001
    SPEDDING, David
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish153095330001
    STUBBINS, Penelope Jane
    6 Austin Road
    WF10 3NN Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Austin Road
    WF10 3NN Castleford
    West Yorkshire
    British109402380001
    SYKES, Elizabeth Ann
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Merefield House
    Whistler Drive
    WF10 5HX Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritish100442900001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    30 ott 2016La società ha identificato una persona registrabile in relazione alla società, ma non sono stati confermati tutti i dati richiesti di tale persona.

    WAKEFIELD AND DISTRICT HOUSING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 mar 2017
    Consegnato il 31 mar 2017
    In corso
    Breve descrizione
    The freehold property known as 8 holme farm mews, pontefract, WF8 3FH registered at the land registry with title number YY5074. For further details, please see the schedule of the charging instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Trustee for the Beneficiaries (Security Trustee)
    Transazioni
    • 31 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Supplemental legal charge
    Creato il 05 apr 2012
    Consegnato il 13 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H (plot 34) 57 redberry avenue hollinbank lane heckmondwike t/no WYK878140 l/h (plot 35) 59 redberry avenue hollinbank lane heckmondwike t/no WYK878142 and l/h (plot 36) 61 redberry avenue hollinbank lane heckmondwike t/no WYK878133 for full list of properties charged please see form MG01 right title and interest in to and under the insurances and all claims and returns of premiums and the benefit of all present and future licences consents and authorisations see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 13 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2005
    Consegnato il 30 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 30 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0