SMART & COOK HOLDINGS LIMITED

SMART & COOK HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSMART & COOK HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04950508
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    • Assicurazioni diverse da quelle sulla vita (65120) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5 Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PINCO 2037 LIMITED03 nov 200303 nov 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 dic 2012

    • Capitale: GBP 1.34
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 28/12/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    19 pagineAR01

    Cessazione della carica di Graham Marshall Coates come amministratore in data 04 ott 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Robert Charles William Organ come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Ian Story come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jane Ann Bean come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Jeremy Peter Small come segretario

    4 pagineAP03

    Nomina di Mr Michael Andrew Bruce come amministratore

    5 pagineAP01

    Nomina di Andrew Kenneth Parsons come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Lisa Mcdonell come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 03 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Graham Story il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Graham Marshall Coates il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Charles Reid il 06 ott 2010

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SMART & COOK HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SMALL, Jeremy Peter
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    British158291880001
    BEAN, Jane Ann
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    EnglandBritish158293780001
    BRUCE, Michael Andrew
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish61928170002
    ORGAN, Robert Charles William
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish124219190002
    PARSONS, Andrew Kenneth
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    UkBritish158284950001
    REID, Stuart Charles
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish60698020001
    MCDONELL, Lisa Michelle
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    Segretario
    50 Valley Drive
    LS29 8PA Ilkley
    West Yorkshire
    British88620750001
    SHAY, Ian Lawton
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    9 Warwick Crescent
    HG2 8JA Harrogate
    North Yorkshire
    British9138100003
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BURN, Bryan Adrian Falconer
    13 Woodthorpe Road
    Putney
    SW15 6UQ London
    Amministratore
    13 Woodthorpe Road
    Putney
    SW15 6UQ London
    EnglandBritish3114720001
    BURNETT, David John Stuart
    Hall Farm
    Wigsthorpe
    PE8 5SE Peterborough
    Northamptonshire
    Amministratore
    Hall Farm
    Wigsthorpe
    PE8 5SE Peterborough
    Northamptonshire
    EnglandBritish42335320002
    COATES, Graham Marshall
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish139593550001
    COOK, Geoffrey Graham
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    Amministratore
    Roxby Manor
    Pickering Road Thornton Le Dale
    YO18 7LH Pickering
    North Yorkshire
    British51386970005
    DRUCKMAN, Darryl Martin
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    Amministratore
    5 Coombe Gardens
    Wimbledon
    SW20 0QU London
    EnglandBritish18047610001
    HOOPER, Shaun Ian
    6 Beckworth Close
    Lindfield
    RH16 2EJ Haywards Heath
    West Sussex
    Amministratore
    6 Beckworth Close
    Lindfield
    RH16 2EJ Haywards Heath
    West Sussex
    EnglandBritish119362420001
    LANE, Angela Claire
    Old Manor Farmhouse
    London Lane, Avon
    BH23 7BL Christchurch
    Dorset
    Amministratore
    Old Manor Farmhouse
    London Lane, Avon
    BH23 7BL Christchurch
    Dorset
    EnglandBritish72210150001
    MEEHAN, Paul Christopher
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    Amministratore
    9 Appleby Court
    Scotton Gates
    HG5 9LU Knareborough
    North Yorkshire
    United KingdomBritish127255230002
    OWEN, David Edward
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    Amministratore
    Willow Cottage
    Saltaire Road Eldwick
    BD16 3EY Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish2400660001
    STORY, Ian Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1AD London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritish75238840004
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76332110001

    SMART & COOK HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 24 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies (other than dividends on any shares) due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • 3I Group PLC
    Transazioni
    • 24 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 19 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Geoffrey Graham Cook
    Transazioni
    • 19 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 08 mar 2004
    Consegnato il 11 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 mag 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0