SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04958135 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| SCOTIA GAS NETWORKS PLC | 27 mag 2005 | 27 mag 2005 |
| SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED | 09 feb 2005 | 09 feb 2005 |
| SCOTARIO LIMITED | 27 ago 2004 | 27 ago 2004 |
| SOUTH OF ENGLAND GAS DISTRIBUTION LIMITED | 24 mag 2004 | 24 mag 2004 |
| DUNWILCO (1109) LIMITED | 10 nov 2003 | 10 nov 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 mar 2026 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 31 dic 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 10 dic 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 24 dic 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 10 dic 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Nicola Anne Shand come segretario in data 06 nov 2025 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025 | 148 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Afonso Castello-Branco Gois come amministratore in data 16 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Mathew David Turnell-Henry come amministratore in data 16 mag 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Felipe Ortiz come amministratore in data 08 mag 2025 | 1 pagine | TM01 | ||
Notifica di Bsip Uk Holdco Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2019 | 2 pagine | PSC02 | ||
Modifica dei dettagli di Bsip Uk Holdco Limited come persona con controllo significativo il 14 mag 2025 | 3 pagine | PSC05 | ||
Notifica di Braeburn Equityco Limited come persona con controllo significativo il 28 feb 2025 | 2 pagine | PSC02 | ||
Modifica dei dettagli di Uk Gas Distribution 2 Limited come persona con controllo significativo il 15 apr 2025 | 3 pagine | PSC05 | ||
Nomina di Mr Fungai Makoni come segretario in data 01 apr 2025 | 2 pagine | AP03 | ||
Nomina di Mr David Demes come amministratore in data 30 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr James Alexander Adam come amministratore in data 30 gen 2025 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Megan Rose Birtwistle come segretario in data 15 gen 2025 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Christian Herbert Fingerle come amministratore in data 13 set 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024 | 154 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Charles Thomazi come amministratore in data 12 giu 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Antoine Jean René Kerrenneur come amministratore in data 15 apr 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr Matthew Jonathan Gross come amministratore in data 04 gen 2024 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Miss Megan Rose Birtwistle come segretario in data 01 nov 2023 | 2 pagine | AP03 | ||
Cessazione della carica di Sharmila Virginia Sylvester come segretario in data 01 nov 2023 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023 | 130 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Antoine Jean René Kerrenneur come amministratore in data 29 mar 2023 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKONI, Fungai | Segretario | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 334490580001 | |||||||
| ADAM, James Alexander | Amministratore | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | England | British,Canadian | 195244550005 | |||||
| BOTHA, Michael John | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Canada | Canadian | 294271520001 | |||||
| BRUNNING, Charlotte Louise | Amministratore | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 242374880001 | |||||
| CATCHPOLE, Martin Paul | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | British | 285580440001 | |||||
| DEMES, David | Amministratore | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | United Kingdom | Slovak | 334083960001 | |||||
| GOIS, Afonso Castello-Branco | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | Portuguese | 335866770001 | |||||
| GROSS, Matthew Jonathan | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United States | American | 318295020001 | |||||
| LUMLOCK, Rebecca Elizabeth | Amministratore | One Canada Square, 25th Floor Canary Wharf E14 5AA London Brookfield United Kingdom | United Kingdom | British | 294141090001 | |||||
| ROSENTHAL, Jeffrey | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Canada | Canadian | 297967760001 | |||||
| SALMON, Nicholas Robin | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | British | 256613430001 | |||||
| SMART, Michael Oswald | Amministratore | 2 St. James's Market SW1Y 4AH London Stepstone Group England | United Kingdom | British | 296382310001 | |||||
| TRIMMER, Paul John Vincent | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | British | 149695050001 | |||||
| TURNELL-HENRY, Mathew David | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | British | 335866750001 | |||||
| ADAMS, Jonathan Jeffrey | Segretario | Station Approach RH6 9HJ Horley St. Lawrence House Surrey United Kingdom | British | 150782130001 | ||||||
| BIRTWISTLE, Megan Rose | Segretario | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 315945900001 | |||||||
| GRAY, Ailsa Mary | Segretario | 27 Saint Magdalenes Road PH2 0BT Perth | British | 52995340008 | ||||||
| HARDING, Debbie Mary | Segretario | Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House, 200 | British | 136476220001 | ||||||
| SHAND, Nicola Anne | Segretario | Station Approach RH6 9HJ Horley St Lawrence House Surrey United Kingdom | British | 162590670001 | ||||||
| SYLVESTER, Sharmila Virginia | Segretario | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | 290375600001 | |||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario nominato | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 900004640001 | |||||||
| ALEXANDER, Fraser Mcgregor | Amministratore | Inveralmond House 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth | United Kingdom | British | 65278040002 | |||||
| BRADBURY, Kenton Edward | Amministratore | 122 Leadenhall Street EC3V 4AB London The Leadenhall Building United Kingdom | United Kingdom | British | 203542960001 | |||||
| COVASSIN, Tanya Maria | Amministratore | 31 Anderson Avenue M5P 1H5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 103424270002 | ||||||
| DOWD, Stephen Donald | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Ontario, Canada | Canadian | 235050150001 | |||||
| FINGERLE, Christian Herbert, Dr | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | Germany | German | 193691880001 | |||||
| FLAGEUL, Natalie Michaela | Amministratore | Langstone Technology Park Langstone Road PO9 1SA Havant Sse Buliding 500 Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164470090002 | |||||
| FLEMING, Neil Patrick | Amministratore | Portman Square W1H 6AZ London 10 United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 201061840001 | |||||
| FRIEDRICHSEN, Adam Michael Cooper | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | England | Canadian | 285245290001 | |||||
| GRUND, Ines | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | German | 250793730001 | |||||
| HOOD, Colin William | Amministratore | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Perthshire | United Kingdom | British | 80184130003 | |||||
| JUGGINS, Graham Gerald | Amministratore | 4 Langley Place PH2 7XB Perth Perthshire | British | 103424030001 | ||||||
| KERRENNEUR, Antoine Jean René | Amministratore | St Lawrence House Station Approach RH6 9HJ Horley Surrey | United Kingdom | French | 308289130001 | |||||
| LAMBERT, Guy | Amministratore | Corniche Street PO BOX 3600 211 Abu Dhabi United Arab Emirates | United Arab Emirates | Dutch | 218197910001 | |||||
| LEPIN, Ronald Kenneth | Amministratore | 66 Howland Avenue Upper Floor M5R 3B3 Toronto Ontario M5r 3b3 Canada | Canadian | 100256500001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SCOTIA GAS NETWORKS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braeburn Equityco Limited | 28 feb 2025 | Portman Square W1H 6AZ London 10 Portman Square England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Uk Gas Distribution 2 Limited | 22 mar 2022 | 22 Grenville Street JE4 8PX Jersey 22 Grenville Street, St Helier, Je4 8px, Jersey Jersey | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Bsip Uk Holdco Limited | 25 lug 2019 | 1 Bartholomew Lane EC2N 2AX London 1 Bartholomew Lane, London, England, Ec2n 2ax England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Sse Plc | 06 apr 2016 | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0