LATIMER GROUP LIMITED
Panoramica
Nome della società | LATIMER GROUP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04966642 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LATIMER GROUP LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova LATIMER GROUP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Weetabix Mills Burton Latimer NN15 5JR Kettering Northhamptonshire |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di LATIMER GROUP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per LATIMER GROUP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 30 giu 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 gen 2018
| 16 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nomina di Richard William Thomas Martin come segretario in data 11 gen 2018 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Christopher David George Thomas come segretario in data 11 gen 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti | 2 pagine | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 lug 2017
| 16 pagine | SH01 | ||||||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD03 | ||||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA | 1 pagine | AD02 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Giles Michael Turrell come amministratore in data 18 ott 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||||||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2016 | 93 pagine | AA | ||||||||||||||
Memorandum e Statuto | 16 pagine | MA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 049666420010 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||||||
Nomina di Sally Jane Abbott come amministratore in data 03 lug 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jianfu Zhao come amministratore in data 03 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Tonghong Wu come amministratore in data 03 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Bin Zhang come amministratore in data 03 lug 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di LATIMER GROUP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Richard William Thomas | Segretario | Burton Latimer NN15 5JR Kettering Weetabix Mills Northants England | 242484600001 | |||||||
ABBOTT, Sally Jane | Amministratore | Station Road NN15 5JR Burton Latimer Weetabix Mills England | England | British | Director | 133862850002 | ||||
MARTIN, Richard William Thomas | Amministratore | Weetabix Mills Burton Latimer NN15 5JR Kettering Northhamptonshire | United Kingdom | British | Director | 37115510005 | ||||
DARWENT, Robert | Segretario | 52 Hasker Street SW3 2LQ London | British | Investor | 72764480004 | |||||
MARTIN, Richard William Thomas | Segretario | Church Barn NN17 3AX Laxton Northamptonshire | British | 37115510005 | ||||||
THOMAS, Christopher David George | Segretario | Weetabix Mills Burton Latimer NN15 5JR Kettering Northhamptonshire | 195970580001 | |||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
BENAZECH, Victor Francois Robert | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HP London 21 United Kingdom | United Kingdom | French | Investor | 189698870001 | ||||
CUI, Guiyong | Amministratore | China Central Place, No. 77 Jian Guo Road Chaoyang District 100025 Beijing Unit 2903-05a, Tower 3 China | China | Chinese | Investment Professional | 200717950001 | ||||
DARWENT, Robert | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 | Bahamas | British | Investor | 72764480006 | ||||
HALSTENBERG, Dominik | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 | England | German | Investment Professional | 114930580002 | ||||
HERBERSTEIN, Johann Maximilian | Amministratore | 10 Kimberley Court Kimberley Road NW6 7LS London | Austrian | Investor | 142652310001 | |||||
LEA, Lyndon | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 | Bahamas | British | Investor | 121737610003 | ||||
LILI, Wang | Amministratore | No 7 Lane 263 Huashan Road Shanghai Bright Food (Group) Limited 200040 P.R.China | P.R.China | Chinese | Vice General Manager Of Bright Food International | 173520480001 | ||||
LIN, Li | Amministratore | No 7 Lane 263 Huashan Road Shanghai Bright Food (Group) Limited 200040 P.R.China | P.R.China | Chinese | General Manager Finance Dept Bright Food (Group) | 173520570001 | ||||
ROSEN, Andrew | Amministratore | 3006 Woodside 5011 Dallas 75201 | Usa | American | Investor | 116038870001 | ||||
SCHOFIELD, Robert John | Amministratore | Hatton Hill GU20 6AD Windlesham Redwood House Surrey England | United Kingdom | British | Director Of Weetabix | 80018490003 | ||||
SURSOCK, Mike | Amministratore | 8 Finance Street Central Hong Kong Suite 3801, Two International Finance Centre Hong Kong | Hong Kong | Greek | Operating Partner | 200717940001 | ||||
TURRELL, Giles Michael | Amministratore | Weetabix Mills Burton Latimer NN15 5JR Kettering Northhamptonshire | United Kingdom | British | Director | 141655480001 | ||||
WU, Tonghong | Amministratore | 376 Zhao Jia Bang Road Xuhui District Shanghai 15f Shanghai 200031 Prc | China | Chinese | Executive | 197681400001 | ||||
XIAOFENG, Cao | Amministratore | No 7 Lane 263 Huashan Road Shanghai Bright Food (Group) Limited 200040 P.R.China | P.R.China | Chinese | Director Of Bright Food Europe Limited | 173520640001 | ||||
YE, Yin | Amministratore | Grosvenor Place SW1X 7HF London 21 United Kingdom | United States Of America | Chinese | Investment Associate | 173522860001 | ||||
ZHANG, Bin | Amministratore | 376 Zhao Jia Bang Road 200031 Shanghai 15f Shanghai Prc | China | Chinese | Vp Of Shanghai No.1 Yimin Foods (Group) Co Ltd | 208316540001 | ||||
ZHANG, Lin | Amministratore | 253 Hua Shan Road 200040 Shanghai No 7 Shanghai Prc | Prc | Chinese | Deputy General Manager | 208316480001 | ||||
ZHAO, Jianfu | Amministratore | 376 Zhao Jia Bang Road 200031 Shanghai 15f Shanghai Prc | China | Chinese | Vice Cfo | 208316620001 | ||||
ZONGNAN, Wang | Amministratore | No 7 Lane 263 Huashan Road Shanghai Bright Food (Group) Limited 20040 P.R.China | P.R.China | Chinese | Director Of Bright Food Europe Limited | 173520200001 | ||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LATIMER GROUP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latimer Holdings Limited | 15 ago 2016 | Burton Latimer NN15 5JR Kettering Weetabix Mills United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LATIMER GROUP LIMITED?
Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
---|---|---|
17 nov 2016 | 15 ago 2016 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
LATIMER GROUP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creato il 26 ott 2015 Consegnato il 05 nov 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Group debenture | Creato il 02 nov 2012 Consegnato il 12 nov 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Group debenture | Creato il 22 nov 2011 Consegnato il 09 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 03 mag 2007 Consegnato il 18 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge | Creato il 23 gen 2006 Consegnato il 30 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties and each mezzanine finance party of any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The intellectual property rights listed in appendix e to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A composite guarantee and debenture | Creato il 22 dic 2005 Consegnato il 05 gen 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A composite guarantee & debenture | Creato il 02 lug 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H land lying on the south side of macadam road corby t/no NN168304, f/h & l/h property being unit a & brook house brook way ivyhouse lane hastings t/no ESX217047 t/no ESX142376 t/no ESX175104, f/h land being south west side of ivyhouse lane hastings t/no ESX183907. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Supplemental deed | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 27 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that f/h land k/a sites 1 and 2 earlstree industrial estate and being land and buildings at the junction of earlstrees road and rockingham road corby t/n NN134520 and NN195622, all that f/h land and buildings on the southwest side of polwell lane burton latimer t/n NN62464, NN713990 and NN86660, all that f/h land being the land lying to the west of polwell lane barton seagrave t/n NN130449, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Composite guarantee and debenture | Creato il 09 dic 2003 Consegnato il 22 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All present and future assets of the of the company, land interest in land fixtures plant machinery and equipment stocks shares bonds and other securities of any kind the debts the benefit of insurances goodwill and uncalled capital intellectual property the target the scheme and the scheme documents the press release the offer and the offer documents floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
A composite guarantee and debenture dated 18TH november 2003 as amended by a supplemental deed | Creato il 04 dic 2003 Consegnato il 05 dic 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from J.P. morgan PLC jpmorgan chase bank and J.P. morgan europe limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0