LATIMER GROUP LIMITED

LATIMER GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLATIMER GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04966642
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LATIMER GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LATIMER GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LATIMER GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LATIMER GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2017 al 30 giu 2018

    1 pagineAA01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 gen 2018

    • Capitale: GBP 130,598.64
    16 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Nomina di Richard William Thomas Martin come segretario in data 11 gen 2018

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Christopher David George Thomas come segretario in data 11 gen 2018

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 nov 2017 senza aggiornamenti

    2 pagineCS01

    legacy

    3 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 03 lug 2017

    • Capitale: GBP 130,586.85
    16 pagineSH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 10-18 Union Street London SE1 1SZ United Kingdom a 100 New Bridge Street London EC4V 6JA

    1 pagineAD02

    Cessazione della carica di Giles Michael Turrell come amministratore in data 18 ott 2017

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2016

    93 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    16 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Soddisfazione dell'onere 049666420010 in pieno

    1 pagineMR04

    Nomina di Sally Jane Abbott come amministratore in data 03 lug 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jianfu Zhao come amministratore in data 03 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Tonghong Wu come amministratore in data 03 lug 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Bin Zhang come amministratore in data 03 lug 2017

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di LATIMER GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MARTIN, Richard William Thomas
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northants
    England
    Segretario
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    Northants
    England
    242484600001
    ABBOTT, Sally Jane
    Station Road
    NN15 5JR Burton Latimer
    Weetabix Mills
    England
    Amministratore
    Station Road
    NN15 5JR Burton Latimer
    Weetabix Mills
    England
    EnglandBritishDirector133862850002
    MARTIN, Richard William Thomas
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    Amministratore
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    United KingdomBritishDirector37115510005
    DARWENT, Robert
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    Segretario
    52 Hasker Street
    SW3 2LQ London
    BritishInvestor72764480004
    MARTIN, Richard William Thomas
    Church Barn
    NN17 3AX Laxton
    Northamptonshire
    Segretario
    Church Barn
    NN17 3AX Laxton
    Northamptonshire
    British37115510005
    THOMAS, Christopher David George
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    Segretario
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    195970580001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENAZECH, Victor Francois Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7HP London
    21
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7HP London
    21
    United Kingdom
    United KingdomFrenchInvestor189698870001
    CUI, Guiyong
    China Central Place, No. 77 Jian Guo Road
    Chaoyang District
    100025 Beijing
    Unit 2903-05a, Tower 3
    China
    Amministratore
    China Central Place, No. 77 Jian Guo Road
    Chaoyang District
    100025 Beijing
    Unit 2903-05a, Tower 3
    China
    ChinaChineseInvestment Professional200717950001
    DARWENT, Robert
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    BahamasBritishInvestor72764480006
    HALSTENBERG, Dominik
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    EnglandGermanInvestment Professional114930580002
    HERBERSTEIN, Johann Maximilian
    10 Kimberley Court
    Kimberley Road
    NW6 7LS London
    Amministratore
    10 Kimberley Court
    Kimberley Road
    NW6 7LS London
    AustrianInvestor142652310001
    LEA, Lyndon
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    BahamasBritishInvestor121737610003
    LILI, Wang
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Amministratore
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseVice General Manager Of Bright Food International173520480001
    LIN, Li
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Amministratore
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseGeneral Manager Finance Dept Bright Food (Group)173520570001
    ROSEN, Andrew
    3006 Woodside 5011
    Dallas
    75201
    Amministratore
    3006 Woodside 5011
    Dallas
    75201
    UsaAmericanInvestor116038870001
    SCHOFIELD, Robert John
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Redwood House
    Surrey
    England
    Amministratore
    Hatton Hill
    GU20 6AD Windlesham
    Redwood House
    Surrey
    England
    United KingdomBritishDirector Of Weetabix80018490003
    SURSOCK, Mike
    8 Finance Street
    Central
    Hong Kong
    Suite 3801, Two International Finance Centre
    Hong Kong
    Amministratore
    8 Finance Street
    Central
    Hong Kong
    Suite 3801, Two International Finance Centre
    Hong Kong
    Hong KongGreekOperating Partner200717940001
    TURRELL, Giles Michael
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    Amministratore
    Weetabix Mills
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Northhamptonshire
    United KingdomBritishDirector141655480001
    WU, Tonghong
    376 Zhao Jia Bang Road
    Xuhui District
    Shanghai
    15f
    Shanghai 200031
    Prc
    Amministratore
    376 Zhao Jia Bang Road
    Xuhui District
    Shanghai
    15f
    Shanghai 200031
    Prc
    ChinaChineseExecutive197681400001
    XIAOFENG, Cao
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    Amministratore
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    200040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseDirector Of Bright Food Europe Limited173520640001
    YE, Yin
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Place
    SW1X 7HF London
    21
    United Kingdom
    United States Of AmericaChineseInvestment Associate173522860001
    ZHANG, Bin
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    Amministratore
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    ChinaChineseVp Of Shanghai No.1 Yimin Foods (Group) Co Ltd208316540001
    ZHANG, Lin
    253 Hua Shan Road
    200040 Shanghai
    No 7
    Shanghai
    Prc
    Amministratore
    253 Hua Shan Road
    200040 Shanghai
    No 7
    Shanghai
    Prc
    PrcChineseDeputy General Manager208316480001
    ZHAO, Jianfu
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    Amministratore
    376 Zhao Jia Bang Road
    200031 Shanghai
    15f
    Shanghai
    Prc
    ChinaChineseVice Cfo208316620001
    ZONGNAN, Wang
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    20040
    P.R.China
    Amministratore
    No 7 Lane 263
    Huashan Road
    Shanghai
    Bright Food (Group) Limited
    20040
    P.R.China
    P.R.ChinaChineseDirector Of Bright Food Europe Limited173520200001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LATIMER GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    United Kingdom
    15 ago 2016
    Burton Latimer
    NN15 5JR Kettering
    Weetabix Mills
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04966644
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per LATIMER GROUP LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    17 nov 201615 ago 2016La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    LATIMER GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 ott 2015
    Consegnato il 05 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transazioni
    • 05 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 02 nov 2012
    Consegnato il 12 nov 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any member of the group to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rabobank International, London Branch
    Transazioni
    • 12 nov 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Group debenture
    Creato il 22 nov 2011
    Consegnato il 09 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 09 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 03 mag 2007
    Consegnato il 18 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited
    Transazioni
    • 18 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 23 gen 2006
    Consegnato il 30 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and each mezzanine finance party of any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The intellectual property rights listed in appendix e to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited or Such Other Person as May Be Appointed Security Agent and Trusteefor the Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 30 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 22 dic 2005
    Consegnato il 05 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited (As Security Agent and Trustee for the Finance Parties and Themezzanine Finance Parties)
    Transazioni
    • 05 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A composite guarantee & debenture
    Creato il 02 lug 2004
    Consegnato il 15 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties and the mezzanine finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land lying on the south side of macadam road corby t/no NN168304, f/h & l/h property being unit a & brook house brook way ivyhouse lane hastings t/no ESX217047 t/no ESX142376 t/no ESX175104, f/h land being south west side of ivyhouse lane hastings t/no ESX183907. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited for Such Other Person as May Be Appointed Security Agent and Trustee for the Finance Parties and the Mezzanine Finance Parties
    Transazioni
    • 15 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 27 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that f/h land k/a sites 1 and 2 earlstree industrial estate and being land and buildings at the junction of earlstrees road and rockingham road corby t/n NN134520 and NN195622, all that f/h land and buildings on the southwest side of polwell lane burton latimer t/n NN62464, NN713990 and NN86660, all that f/h land being the land lying to the west of polwell lane barton seagrave t/n NN130449, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited or Other Such Person as May Be Appointed Security Agent and Trusteefor the Finance Parties
    Transazioni
    • 27 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 feb 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 09 dic 2003
    Consegnato il 22 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All present and future assets of the of the company, land interest in land fixtures plant machinery and equipment stocks shares bonds and other securities of any kind the debts the benefit of insurances goodwill and uncalled capital intellectual property the target the scheme and the scheme documents the press release the offer and the offer documents floating charge over all other present and future assets of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties
    Transazioni
    • 22 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A composite guarantee and debenture dated 18TH november 2003 as amended by a supplemental deed
    Creato il 04 dic 2003
    Consegnato il 05 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from J.P. morgan PLC jpmorgan chase bank and J.P. morgan europe limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • J.P. Morgan Europe Limited Acting as Security Agent for the Finance Parties Pursuant to Thefacilities Agreement
    Transazioni
    • 05 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0