BUSY BEES GROUP LIMITED

BUSY BEES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBUSY BEES GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04968957
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BUSY BEES GROUP LIMITED?

    • (9305) /

    Dove si trova BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Busy Bees At St Matthews
    Shaftsbury Drive
    WS7 9QP Burntwood
    Staffordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BROOMCO (3333) LIMITED19 nov 200319 nov 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Struck off register 30/09/2011
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    Cessazione della carica di Adam Loren Cohn come amministratore in data 29 set 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Peter Maslen come amministratore in data 29 set 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Elanna Sharon Yalow come amministratore in data 29 set 2011

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stanley Elliot Maron come amministratore in data 29 set 2011

    2 pagineTM01

    Stato del capitale al 29 set 2011

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Cancellation of share premium account 29/09/2011
    RES13

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    7 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    legacy

    9 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 19 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2009 al 31 dic 2009

    1 pagineAA01

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di BUSY BEES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Segretario
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    British55976790005
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Amministratore
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    British9070120002
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Segretario
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    ANTHONY, Larry
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Amministratore
    476 Tweed Valley Way
    Murwillumbah
    New South Wales 2484
    Australia
    Australian119252580001
    BANNAN, Jillian Glenda
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Amministratore
    47 Tooth Avenue
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530620001
    BARBOUR SMITH, James Kenneth Alexander
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    The Square House
    Latchmoor Grove
    SL9 8LN Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British80175630001
    BLACK, James
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Amministratore
    103 Howard Street
    Paddington
    Queensland Qld 4064
    Australia
    Australian117530480001
    COHN, Adam Loren
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    Amministratore
    Stone Canyon Road
    Los Angeles
    1221
    California Ca 90077
    Usa
    United StatesAmerican179538540001
    GALLAGHER, Patrick
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Amministratore
    Hawden Street
    4051
    Wilston
    21
    Queenstown
    Australia
    Australian130462890001
    HORTON, Mathew
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Amministratore
    Kennedy Terrace
    4064
    Paddington
    50
    Queensland
    Australia
    Australian130462790001
    IRONS, Simon Andrew
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    Amministratore
    The Cottage
    The Grange High Street
    ST14 8LD Marchington
    EnglandBritish55976790005
    MARON, Stanley Elliot
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    Amministratore
    440 21st Street
    Santa Monica
    California 90402
    Usa
    United StatesAmerican94599720001
    MASLEN, Peter
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    Amministratore
    Cuscaden Road, #16-01
    Singapore
    20
    249726
    Singapore
    SingaporeAustralian138244750001
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    RANDLES, Margaret Josephine
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    222 Beacon Street
    WS13 7BH Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish9070120002
    SPOTTISWOODE, Clare Mary Joan
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    Amministratore
    39 Lonsdale Square
    N1 1EW London
    United KingdomBritish45303770001
    THACKRAY, David Ian
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    37 Burton Old Road
    WS13 6EN Lichfield
    Staffordshire
    British9070100001
    WALSH, Julia Maria, Dr
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    Amministratore
    Wind In The Willows
    Moorhouse Farm Lane Lower Road
    UB8 5EN Higher Denham
    Bucks
    UkBritish47545490001
    WAUGH, John
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    Amministratore
    Dudley Street
    4065
    Bardon
    35a
    Queensland
    Australia
    New Zealander130463000001
    WOODWARD, John Brian
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    Amministratore
    75 Upper Way
    Upper Longdon
    WS15 1QD Rugeley
    Staffordshire
    EnglandBritish9070090003
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    WOODWARD, Lynn Carol
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    33 Cherry Orchard
    WS14 9AN Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritish3850190004
    YALOW, Elanna Sharon
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    Amministratore
    Holcomb Avenue
    Larkspur
    427
    California Ca94939
    United States
    UsaUnited States138244770001
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    BUSY BEES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite debenture
    Creato il 21 dic 2010
    Consegnato il 30 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental charge
    Creato il 04 mar 2010
    Consegnato il 06 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent)
    Transazioni
    • 06 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 05 giu 2009
    Consegnato il 16 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Princess christian college wilbraham road fallowfields manchester. Chester street, aston lock south birmingham, land on the west side of manton lane bedford. For further properties please see form 395 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 feb 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 mag 2005
    Consegnato il 14 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the noteholders or to the trustee (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barrington House Nominees Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 10 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1 (one) ordinary share of £1 issued by broomco (3347) limited (co no 4968447 together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    70,000 a ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees hroup limited (co no 3895685); 900 b ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685; 2 c ordinary shares of £0.10 each issued by busy bees group limited (co no 3895685) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over shares
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    600,000 ordinary shares of £1.00 each issued by burntwood holdings limited )co no 03840104) together with all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 giu 2004
    Consegnato il 24 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a broomco (3333) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 24 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0