VISUL HOMES UK LIMITED

VISUL HOMES UK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVISUL HOMES UK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04972563
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VISUL HOMES UK LIMITED?

    • (4521) /
    • (7011) /

    Dove si trova VISUL HOMES UK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VISUL HOMES UK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VISUAL HOMES UK LIMITED21 nov 200321 nov 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di VISUL HOMES UK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2007

    Quali sono le ultime deposizioni per VISUL HOMES UK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di conto finale prima della dissoluzione

    16 pagineWU15

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    20 pagineWU07

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    19 pagineWU07

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU a 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB in data 15 nov 2018

    2 pagineAD01

    Rapporto di avanzamento in una liquidazione da parte del tribunale

    20 pagineWU07

    Nomina di un liquidatore

    3 pagineWU04

    Indirizzo della sede legale modificato da Beeding Manor Pound Lane Upper Beeding Steyning West Sussex BN44 3JD a C/O Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU in data 26 giu 2017

    2 pagineAD01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 16 ago 2016

    12 pagine1.3

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    14 pagineCVA4

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 16 ago 2015

    12 pagine1.3

    Nomina di Rikki Hope come segretario in data 20 apr 2014

    2 pagineAP03

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 16 ago 2014

    12 pagine1.3

    Nomina di Kyle Oliver Hope come amministratore in data 06 apr 2014

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Madeleine Joanne Lambert come segretario in data 06 apr 2014

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Jeffrey Ernest Hope come amministratore in data 06 apr 2014

    2 pagineTM01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 16 ago 2013

    16 pagine1.3

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 16 ago 2012

    14 pagine1.3

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 13 gen 2011

    2 pagine3.6

    legacy

    2 pagineLQ02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 ago 2010

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 28 feb 2010

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 ago 2009

    2 pagine3.6

    Chi sono gli amministratori di VISUL HOMES UK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HOPE, Rikki
    Castle Lane
    BN44 3PB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    Segretario
    Castle Lane
    BN44 3PB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    British193104770001
    HOPE, Kyle Oliver
    Castle Lane
    BN44 3FB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    England
    Amministratore
    Castle Lane
    BN44 3FB Bramber
    Hoppits
    West Sussex
    England
    EnglandBritish190874780001
    HOPE, Jeffrey Ernest
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    Segretario
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    British29203820002
    LAMBERT, Madeleine Joanne
    Beeding Manor
    Pound Lane Upper Beeding
    BN44 3JD Steyning
    West Sussex
    Segretario
    Beeding Manor
    Pound Lane Upper Beeding
    BN44 3JD Steyning
    West Sussex
    British116755060001
    ROWBOTHAM, Brian
    23 Westlake Gardens
    BN13 1LF Worthing
    West Sussex
    Segretario
    23 Westlake Gardens
    BN13 1LF Worthing
    West Sussex
    British5997360001
    THEYDON SECRETARIES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Segretario nominato
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900011300001
    HOPE, Jeffrey Ernest
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    Amministratore
    Beeding Manor Pound Lane
    Upper Beeding
    BN44 3JB Steyning
    West Sussex
    British29203820002
    MARSDEN, Neil Alexander Leslie
    1 Copperfields Close
    Kemsing
    TN15 6QW Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    1 Copperfields Close
    Kemsing
    TN15 6QW Sevenoaks
    Kent
    British111810520001
    THEYDON NOMINEES LIMITED
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    Amministratore delegato nominato
    25 Hill Road
    Theydon Bois
    CM16 7LX Epping
    Essex
    900010330001

    VISUL HOMES UK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 07 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H unit 1 noble square industrial estate brynmawr south wales t/no wa 625727 together by way of first fixed charge all tools, equipment, plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart James Davies
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 07 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H unit 1 noble square industrial estate brynmawr south wales t/no wa 625727 together by way of fixed charge the benefit of all deeds, agreement, contracts and warranties relating to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart James Davies
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 14 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 noble square brynmawr gwent t/no. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 13 nov 2006
    Consegnato il 14 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Unit 1 noble square brynmawr gwent t/no WA625727.
    Persone aventi diritto
    • Lancashire Mortgage Corporation Limited
    Transazioni
    • 14 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being unit 1 noble square industrial estate brynmawr blaenau gwent t/no WA625727 f/h property k/a or being fforchneol park (also k/a land at pantyfedwen) cwmaman aberdare t/no CYM2. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgebank Capital Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 ott 2007Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Legal charge
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being land at fforchneol park (also k/a pantyfedwen) cwmamen aberdare t/no CYM273270. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgebank Capital Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 120 gen 2011Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 26 lug 2006
    Consegnato il 28 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a or being unit 1 noble square industrial estate brynmawr blaenau gwent t/no WA625727. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridgebank Capital Limited
    Transazioni
    • 28 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 22 giu 2006
    Consegnato il 04 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 04 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 ago 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 08 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at pantyfedwen, cwmaman, aberdare t/n WA400530 fixed charge the benefit of all deeds agreements contracts and warranties, by way of assignment the goodwill and all the income together with the rights and remedies, all monies pursuant to all contracts or policies of insurance and the benefit of all licences and authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transazioni
    • 08 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 08 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 1 noble square, brynmawr t/n WA625727 fixed charge the benefit of all deeds agreements contracts and warranties, by way of assignment the goodwill and all the income together with the rights and remedies, all monies pursuant to all contracts or policies of insurance and the benefit of all licences and authorisations. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transazioni
    • 08 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 08 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 1 noble square, brynmawr t/n WA625727 and pantyfedwen, cwmaman, aberdare t/n WA400530. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stewart James Davies and Gene Melvin Laughton
    Transazioni
    • 08 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second legal charge
    Creato il 29 set 2005
    Consegnato il 06 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a unit 1, noble square industrial estate, brynmawr, gwent t/n WA625727 including all buildings, fixtures and fittings and fixed plant and machinery thereon.
    Persone aventi diritto
    • Visual Designs Limited
    Transazioni
    • 06 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 nov 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    VISUL HOMES UK LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary Bell
    Cowgill Holloway
    49 Peter Street
    M2 3NG Manchester
    Ricevitore/gestore
    Cowgill Holloway
    49 Peter Street
    M2 3NG Manchester
    2
    DataTipo
    17 ago 2011Data della riunione per approvare il CVA
    12 apr 2017Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Susan Agnes Maund
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Praticante
    White Maund Llp
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Andrew White
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    Praticante
    44-46 Old Steine
    BN1 1NH Brighton
    East Sussex
    3
    DataTipo
    28 set 2020Conclusione della liquidazione
    13 feb 2017Data della petizione
    12 apr 2017Inizio della liquidazione
    08 mar 2021Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Croydon
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Praticante
    11th Floor Southern House
    Wellesley Grove
    CR0 1XN Croydon
    Ben Woolrych
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    Frp Advisory Llp 7th Floor Ship Canal House
    98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0