EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04975199 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
- Attività di agenti e broker di assicurazione (66220) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Ageas House Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Hampshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| GW 1165 LIMITED | 25 nov 2003 | 25 nov 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Fernley Keith Dyson come amministratore in data 31 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 14 pagine | AA | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 13 ago 2018
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Anthony Edward Middle il 23 apr 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Fernley Keith Dyson il 29 dic 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Stato del capitale al 15 dic 2017
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Kwik-Fit Insurance Services Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 049751990002 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 25 nov 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jason David Banwell come amministratore in data 01 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Stuart Watson come amministratore in data 01 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicholas James Lemans come amministratore in data 01 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Richard John Furse come amministratore in data 01 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Rosemary Anne | Segretario | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | 153431020001 | |||||||
| MIDDLE, Anthony Edward | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire | England | British | 129283070002 | |||||
| JOHNSON, Bryan Kenneth | Segretario | 10 Ashmead Drive Rednal B45 8AA Birmingham West Midlands | English | 2038430001 | ||||||
| LAWSON, Barry Alexander | Segretario | Fernlea Bearsden G61 1NB Glasgow 36 United Kingdom | British | 115764610003 | ||||||
| LYNCH, June | Segretario | Masterton Way Tannochside Business Park G71 5PU Uddington 1 | British | 147599610001 | ||||||
| GW SECRETARIES LIMITED | Segretario | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 93128710001 | |||||||
| BALL, Gregor Frank | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire | United Kingdom | British | 108633100001 | |||||
| BANWELL, Jason David | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 182498480001 | |||||
| BRIGHT, Robert Stewart | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | England | British | 145809660001 | |||||
| BROWN, Alan | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | Scotland | British | 135011840001 | |||||
| CLIFF, Mark | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 197694550001 | |||||
| DEVINE, Brendan | Amministratore | Masterton Way Tannochside Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 | United Kingdom | British | 113265830001 | |||||
| DYSON, Fernley Keith | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 127180610002 | |||||
| FRASER, Ian Ellis | Amministratore | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | Scotland | Uk | 28393850006 | |||||
| FRIEND, Peter Richard Henry | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | England | British | 14914420007 | |||||
| FURSE, James Richard John | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire | England | British | 147085440001 | |||||
| HARVEY, Julian Robert Mark | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 161523620001 | |||||
| HEALY, Michael Joseph Anthony | Amministratore | East Main Street EH52 5AS Broxburn 216 West Lothian | United Kingdom | British | 99111340001 | |||||
| HUGHES, Leo Joseph | Amministratore | Little Fulford Farm Tanners Green Lane B94 5JT Earlswood Solihull | United Kingdom | British | 17781220002 | |||||
| JOHNSON, Bryan Kenneth | Amministratore | 10 Ashmead Drive Rednal B45 8AA Birmingham West Midlands | England | English | 2038430001 | |||||
| LEMANS, Nicholas James | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 114355520002 | |||||
| LYNCH, June | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 154407880002 | |||||
| MORONEY, Peter Antony | Amministratore | 1 Wyatts Way Ashill TA19 9NY Ilminster Somerset | England | British | 59422920002 | |||||
| OLIVER, David Martin | Amministratore | 13 Kirklee Circus G12 0TW Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 115764650001 | |||||
| SMITH, Barry Duncan | Amministratore | Tollgate Chandler's Ford SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 47378680003 | |||||
| WATSON, Andrew Stuart | Amministratore | Hampshire Corporate Park Templars Way SO53 3YA Eastleigh Ageas House Hampshire United Kingdom | England | British | 124578530001 | |||||
| WOODBURN, Christopher Hugh | Amministratore | Masterton Way Tannochside Park, Uddingston G71 5PU Glasgow 1 | United Kingdom | British | 105978720001 | |||||
| GW INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore | One Eleven Edmund Street B3 2HJ Birmingham West Midlands | 68279000003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kwik-Fit Insurance Services Limited | 06 apr 2016 | Masterton Way, Tannochside Business Park Uddingston G71 5PU Glasgow 1 Scotland Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
EXPRESS INSURANCE SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 17 set 2014 Consegnato il 27 set 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed & floating charge | Creato il 20 set 2011 Consegnato il 24 set 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0