MENDIP LAND LIMITED

MENDIP LAND LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMENDIP LAND LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04980972
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MENDIP LAND LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova MENDIP LAND LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    7a Howick Place
    SW1P 1DZ London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MENDIP LAND LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STAMPVOCAL LIMITED01 dic 200301 dic 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di MENDIP LAND LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 feb 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per MENDIP LAND LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Nomina di Mr Matthew Richard Potter come amministratore in data 25 set 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Bradley David Cassels come amministratore in data 29 set 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio redatto al 29 feb 2016

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael Henry Marx come amministratore in data 29 feb 2016

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Upton come amministratore in data 08 feb 2016

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Bradley David Cassels come amministratore in data 08 feb 2016

    2 pagineAP01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 049809720008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 049809720007 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 dic 2015

    Stato del capitale al 23 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Henry Marx il 09 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Simon Weiner il 09 nov 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Chris Barton il 09 nov 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 28 feb 2015

    20 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS a 7a Howick Place London SW1P 1DZ in data 11 nov 2015

    1 pagineAD01

    Nomina di Mr Chris Barton come segretario in data 05 gen 2015

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Marcus Owen Shepherd come segretario in data 05 gen 2015

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 dic 2014

    Stato del capitale al 24 dic 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 28 feb 2014

    16 pagineAA

    Nomina di Mr Marcus Owen Shepherd come segretario in data 01 set 2014

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Helen Maria Ratsey come segretario in data 01 set 2014

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di MENDIP LAND LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARTON, Chris
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Segretario
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    194344050001
    POTTER, Matthew Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    EnglandBritish207231520001
    UPTON, Richard
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    EnglandBritish204950320001
    WEINER, Matthew Simon
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish72888710002
    LANES, Stephen Alec
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    Segretario
    Thorpe House 105 Mycenae Road
    Blackheath
    SE3 7RX London
    British1266100003
    LANGRIDGE, Megan Joy
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    Segretario
    42 Everest Drive
    Hoo St Werburgh
    ME3 9AW Rochester
    Kent
    British86459820005
    O REILLY NEENAN, Marie
    Pump House
    Kilmurry Sixmilebridge
    IRISH Ennis
    County Clare
    Ireland
    Segretario
    Pump House
    Kilmurry Sixmilebridge
    IRISH Ennis
    County Clare
    Ireland
    Irish112443260001
    RATSEY, Helen Maria
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    British158444560001
    SHEPHERD, Marcus Owen
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    Segretario
    Bressenden Place
    SW1E 5DS London
    Portland House
    England
    England
    190695330001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    CASSELS, Bradley David
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish130724370005
    HAMMOND, Arnold David
    PO BOX 4532
    8 Mandarina St
    Casearea
    38900
    Israel
    Amministratore
    PO BOX 4532
    8 Mandarina St
    Casearea
    38900
    Israel
    British96187460001
    HAMMOND, Oliver James
    26 Lewes Way
    Croxley Green
    WD3 3SN Rickmansworth
    Hertfordshire
    Amministratore
    26 Lewes Way
    Croxley Green
    WD3 3SN Rickmansworth
    Hertfordshire
    United KingdomBritish54758590002
    KLIMT, Peter Richard
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    Amministratore
    Redington Road
    NW3 7RS London
    54
    United KingdomBritish23621230001
    LAKER, John Frederick
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    Amministratore
    57 Greenways
    KT10 0QH Hinchley Woods
    Surrey
    United KingdomBritish54651510001
    MARSH, John Charles
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    115 Upper Grosvenor Road
    TN1 2EA Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish85346010001
    MARX, Michael Henry
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    Amministratore
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    United KingdomBritish35019090001
    NAGGAR, Guy Anthony
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    Amministratore
    Avenue Road
    NW8 6HR London
    61
    United KingdomItalian1496660001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MENDIP LAND LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Howick Place
    SW1P 1DZ London
    7a
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05755148
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MENDIP LAND LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 15 mag 2014
    Consegnato il 23 mag 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 23 mag 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 ott 2013
    Consegnato il 01 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 01 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A tenth supplemental trust deed
    Creato il 03 feb 2009
    Consegnato il 05 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £20,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. F/h 18 priory road wells somerset t/no ST99267. F/h kwik-fit depot wells somerset t/no ST105789. F/h 38 market street wells somerset t/no ST68067 and WS30048 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alliance Assurance Company Limited
    Transazioni
    • 05 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment
    Creato il 26 nov 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The F.h land known as 18 priory road wells ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells t/n ST68067 f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n ST105789,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed supplemental to a deed of legal charge dated 30 august 2002
    Creato il 26 nov 2004
    Consegnato il 10 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h land known as 18 priory road wells t/n ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells part st 68067, f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n st 105789, together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any),. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Norwich Union Mortgage Finance Limited
    Transazioni
    • 10 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 12 mag 2004
    Consegnato il 15 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage f/h property k/a autospeed tyre & exhaust depot, princes road, wells, mendip, somerset (more recently k/a the kwik fit depot, princes road, wells) t/n ST105789. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 17 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 feb 2004
    Consegnato il 17 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All that f/h property known as 18 priory road, wells, mendip, somerset BA5 1SY t/n ST99267. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 17 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 mar 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0