MENDIP LAND LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MENDIP LAND LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04980972 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MENDIP LAND LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova MENDIP LAND LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 7a Howick Place SW1P 1DZ London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di MENDIP LAND LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| STAMPVOCAL LIMITED | 01 dic 2003 | 01 dic 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di MENDIP LAND LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 29 feb 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per MENDIP LAND LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Matthew Richard Potter come amministratore in data 25 set 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Bradley David Cassels come amministratore in data 29 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 23 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 29 feb 2016 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Henry Marx come amministratore in data 29 feb 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Upton come amministratore in data 08 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Bradley David Cassels come amministratore in data 08 feb 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 6 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 049809720008 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 049809720007 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Henry Marx il 09 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Matthew Simon Weiner il 09 nov 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Chris Barton il 09 nov 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2015 | 20 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Portland House Bressenden Place London SW1E 5DS a 7a Howick Place London SW1P 1DZ in data 11 nov 2015 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Chris Barton come segretario in data 05 gen 2015 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Marcus Owen Shepherd come segretario in data 05 gen 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 dic 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 28 feb 2014 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Marcus Owen Shepherd come segretario in data 01 set 2014 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Helen Maria Ratsey come segretario in data 01 set 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MENDIP LAND LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTON, Chris | Segretario | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | 194344050001 | |||||||
| POTTER, Matthew Richard | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a | England | British | 207231520001 | |||||
| UPTON, Richard | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | England | British | 204950320001 | |||||
| WEINER, Matthew Simon | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 72888710002 | |||||
| LANES, Stephen Alec | Segretario | Thorpe House 105 Mycenae Road Blackheath SE3 7RX London | British | 1266100003 | ||||||
| LANGRIDGE, Megan Joy | Segretario | 42 Everest Drive Hoo St Werburgh ME3 9AW Rochester Kent | British | 86459820005 | ||||||
| O REILLY NEENAN, Marie | Segretario | Pump House Kilmurry Sixmilebridge IRISH Ennis County Clare Ireland | Irish | 112443260001 | ||||||
| RATSEY, Helen Maria | Segretario | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England | British | 158444560001 | ||||||
| SHEPHERD, Marcus Owen | Segretario | Bressenden Place SW1E 5DS London Portland House England England | 190695330001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| CASSELS, Bradley David | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 130724370005 | |||||
| HAMMOND, Arnold David | Amministratore | PO BOX 4532 8 Mandarina St Casearea 38900 Israel | British | 96187460001 | ||||||
| HAMMOND, Oliver James | Amministratore | 26 Lewes Way Croxley Green WD3 3SN Rickmansworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 54758590002 | |||||
| KLIMT, Peter Richard | Amministratore | Redington Road NW3 7RS London 54 | United Kingdom | British | 23621230001 | |||||
| LAKER, John Frederick | Amministratore | 57 Greenways KT10 0QH Hinchley Woods Surrey | United Kingdom | British | 54651510001 | |||||
| MARSH, John Charles | Amministratore | 115 Upper Grosvenor Road TN1 2EA Tunbridge Wells Kent | United Kingdom | British | 85346010001 | |||||
| MARX, Michael Henry | Amministratore | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | United Kingdom | British | 35019090001 | |||||
| NAGGAR, Guy Anthony | Amministratore | Avenue Road NW8 6HR London 61 | United Kingdom | Italian | 1496660001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MENDIP LAND LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Development Securities (Wells) Limited | 06 apr 2016 | Howick Place SW1P 1DZ London 7a United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MENDIP LAND LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 15 mag 2014 Consegnato il 23 mag 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 25 ott 2013 Consegnato il 01 nov 2013 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A tenth supplemental trust deed | Creato il 03 feb 2009 Consegnato il 05 feb 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito £20,000,000 and all other monies due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All buildings and erections and fixtures and fixed plant and machinery. F/h 18 priory road wells somerset t/no ST99267. F/h kwik-fit depot wells somerset t/no ST105789. F/h 38 market street wells somerset t/no ST68067 and WS30048 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment | Creato il 26 nov 2004 Consegnato il 10 dic 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The F.h land known as 18 priory road wells ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells t/n ST68067 f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n ST105789,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental deed supplemental to a deed of legal charge dated 30 august 2002 | Creato il 26 nov 2004 Consegnato il 10 dic 2004 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from starlight investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h land known as 18 priory road wells t/n ST99267 f/h land known as land on the south side of market street wells part st 68067, f/h land known as kwik fit depot princes road wells t/n st 105789, together with all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fittings thereon. All monies deposited with the trustee. By way of floating charge all property assets rights revenues present and future including uncalled share capital (if any),. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 mag 2004 Consegnato il 15 mag 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari By way of legal mortgage f/h property k/a autospeed tyre & exhaust depot, princes road, wells, mendip, somerset (more recently k/a the kwik fit depot, princes road, wells) t/n ST105789. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 17 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 feb 2004 Consegnato il 17 feb 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari All that f/h property known as 18 priory road, wells, mendip, somerset BA5 1SY t/n ST99267. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0