AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 04985335
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    • Intermediazione finanziaria non classificata altrove (64999) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HORIZON GROUP FINANCING LIMITED 04 dic 200304 dic 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di David Phillimore Clifford come amministratore in data 28 mar 2018

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2018

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2017

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Sui Sang Leung come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Henry Maxwell Oliver come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Simon Stuart Wilcox come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominic Gibb come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Hilke Farina come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Chris Blease come amministratore in data 22 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dettagli del segretario cambiati per Amicushorizon Limited il 22 mag 2017

    1 pagineCH04

    Memorandum e Statuto

    15 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 dic 2016 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2016

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 dic 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    14 pagineAA

    Nomina di Mrs Hilke Farina come amministratore in data 21 mag 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Simon Stuart Wilcox come amministratore in data 01 mag 2015

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OPTIVO
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Grosvenor House
    Surrey
    United Kingdom
    Forma giuridicaCOMMUNITY BENEFIT SOCIETY
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleCO-OPERATIVE & COMMUNITY BENEFIT ACT 2011
    Numero di registrazione7561
    81186300007
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Segretario
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    AARONS, Leslie Ian
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    Amministratore
    Briarwood House
    11 Briarwood Hill
    CR8 3LF Purley
    Surrey
    British103151160001
    BAKER, Trevor Charles
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    Amministratore
    54 Lombard Street
    EC3P 3AH London
    British26767780006
    BLEASE, Chris
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish174349810001
    BURKE, Martin Joseph
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    Amministratore
    31 Garrard Road
    SM7 2ER Banstead
    Surrey
    EnglandBritish80091720001
    CAMPBELL, Rory Gerald Peter
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Amministratore
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303270001
    CHILEMBA, Harneck
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Amministratore
    112b Erlanger Road
    Telegraph Hill Park
    SE14 5TJ London
    Malawian96356850001
    CLIFFORD, David Phillimore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish197049630001
    COOPER, Peter Harry
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish100351860001
    CRUTTENDEN, Peter
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish79421300001
    CUDD, John Charles
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    Amministratore
    4 Walnut Tree Walk
    BN20 9BP Eastbourne
    East Sussex
    EnglandBritish113934990001
    DICKINSON MA, David John
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish139132630001
    EVANS, Daniel
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Amministratore
    Trowers & Hamlins
    Sceptre Court 40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    British94303280001
    FALCONER, Charles Leslie, Lord
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish36324370001
    FARINA, Hilke
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandIrish200319020001
    GIBB, Dominic
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish187068870001
    HARLAND, Stuart
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    Amministratore
    Knellstone House
    Udimore
    TN31 6AR Rye
    East Sussex
    British114759590001
    HARRIOTT, Stephen
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    Amministratore
    6 Quay Court
    Westmeads Road
    CT5 1QZ Whitstable
    Kent
    British113561590001
    HOLES, Eric
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    Amministratore
    2 Stable Courtyard
    Chelwood Vachery
    TN22 3HR Nutley
    East Sussex
    EnglandBritish90452390001
    INGRAM, Owen
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    Amministratore
    6 Arbor Close
    BR3 6TW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish103630530001
    KOTTEGODA, Siraj, Mr.
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish99206180001
    LEUNG, Stephen Sui Sang
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish196161690001
    NEWSAM, Denise Feshina Philippa
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    Amministratore
    32 Garlies Road
    Forest Hill
    SE23 2RT London
    United KingdomBritish96357030001
    OLASODE, Olusegun Ayodeji, Dr
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    Amministratore
    New Orchard House
    2a Monks Orchard Road, West Wickham
    BR3 3BW Beckenham
    Kent
    United KingdomBritish52287010003
    OLIVER, David Henry Maxwell
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish67052550001
    PANTER, Andrew
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish52734470001
    SMITH, Dennis Michael
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    Amministratore
    Treetops 57 Battery Hill
    Fairlight
    TN35 4AP Hastings
    East Sussex
    United KingdomBritish69832870003
    SMITH, Sarah Anne
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    United KingdomBritish127972360001
    STARKE, Christopher Charles
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    35 Byng Road
    TN4 8EG Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritish62786710003
    WALKER, Stephen
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    UkBritish113110240002
    WILCOX, Simon Stuart
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    Amministratore
    Grosvenor House
    125 High Street
    CR0 9XP Croydon
    Surrey
    EnglandBritish198724310001
    WILSON, Ben
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    Amministratore
    Apartment 17 Tower 1
    416 Manchester Road
    E14 3RD London
    EnglandBritish90171030001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    04 dic 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    AMICUSHORIZON GROUP FINANCING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Fixed charge
    Creato il 06 gen 2011
    Consegnato il 13 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the chargor's rights title and interest from time to time in and to each of the following assets the facilities account and all moneys now or at any time in future standing to the credit of the facilities account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 13 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 22 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge the whole of the chargor's undertaking and assets present and future all rights and claims to which the chargor is now or may hereafter become entitled in relation to all moneys now or at any time hereafter standing to the credit of the agf sinking fund together with all the rights relating of attaching hereto see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed charge
    Creato il 14 feb 2007
    Consegnato il 02 mar 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the right title and interest from time to time in and to each of the following assets, the facilities account and all rights and claims in relation to all moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited (Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 mar 2004
    Consegnato il 15 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights and claims in relation to all moneys standing to the credit of the hgf sinking fund together with all rights relating or attaching thereto, all rights of the chargor under or in respect of the documents,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Prudential Trustee Company Limited as Security Trustee on Behalf of the Beneficiaries
    Transazioni
    • 15 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 set 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0