MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED

MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04993066
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    • Concessione di credito da parte di istituti finanziari non depositari e altri concedenti specializzati di credito al consumo (64921) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Toronto Square
    Toronto Street
    LS1 2HJ Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 4024 LIMITED11 dic 200311 dic 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di beni vacanti

    1 pagineBONA

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB United Kingdom in data 05 ott 2012

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 24 set 2012

    LRESSP

    Dettagli del direttore cambiati per Michelle Helen Elizabeth Pinggera il 01 dic 2011

    3 pagineCH01

    Cessazione della carica di Jeff Stolz come amministratore in data 23 ott 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Kevin Gasvoda come amministratore in data 01 gen 2012

    1 pagineTM01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 12 dic 2011

    16 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 feb 2012

    Stato del capitale al 15 feb 2012

    • Capitale: GBP 15,153,688
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    13 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Highbridge Oxford Road Uxbridge Middlesex UB8 1HR in data 08 apr 2011

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 12 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio annuale redatto al 11 dic 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Kirsten Pullan come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 gen 2010

    • Capitale: GBP 13,767,688
    2 pagineSH01

    Bilancio annuale redatto al 11 dic 2009 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Kevin Gasvoda il 08 gen 2010

    2 pagineCH01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 17 dic 2009

    • Capitale: GBP 13,767,688
    2 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Allot shares section 551 20/10/2009
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 20 ott 2009

    • Capitale: GBP 13,767,688
    2 pagineSH01

    Chi sono gli amministratori di MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COLLINS, Shaun Anthony, Mr.
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Amministratore
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    EnglandBritish163985940001
    PINGGERA, Michelle Helen Elizabeth
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Amministratore
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    EnglandBritish127185840001
    PULLAN, Kirsten Alexandra
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Segretario
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Other129462570001
    SPIELMANN, Karl Gordon
    6 Maxwell Road
    HP9 1QZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Segretario
    6 Maxwell Road
    HP9 1QZ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British80702700002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    ARCHER, Foster
    Ramblers
    Highfield Road
    TW16 6DL Sunbury On Thames
    Middlesex
    Amministratore
    Ramblers
    Highfield Road
    TW16 6DL Sunbury On Thames
    Middlesex
    United KingdomIrish68207500001
    BLUNDELL, Roger Frederick Crawford
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    Amministratore
    Vineyard Hill Road
    SW19 7JL London
    61
    EnglandBritish56525730002
    BRENNAN, Peter
    Nightingales
    Scotswood Close Penn Road
    HP9 2LJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Nightingales
    Scotswood Close Penn Road
    HP9 2LJ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British84912240002
    COLSELL, Steven James
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    Amministratore
    Limes House
    Bytham Road Ogbourne St George
    SN8 1TD Marlborough
    Wiltshire
    EnglandBritish101387770001
    DAVIES, Stephen
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Amministratore
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    EnglandBritish66245130002
    GASVODA, Kevin
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Amministratore
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    UsaUsa127186570001
    GEORGE, Philip Anthony
    Ickenham Road
    Ruislip
    HA4 8BZ Middlesex
    53
    Amministratore
    Ickenham Road
    Ruislip
    HA4 8BZ Middlesex
    53
    United KingdomBritish131304410001
    JOHNSON, David
    12 The Witherings
    Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    Amministratore
    12 The Witherings
    Emerson Park
    RM11 2RA Hornchurch
    Essex
    British127119390001
    JONES, David Gareth
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Hillhouse Farm
    Misbrooks Green Road Beare Green
    RH5 4QQ Dorking
    Surrey
    United KingdomBritish6205890002
    KINGDON, Simon Charles
    Flint Meadow
    Hockley Lane Stoke Poges
    SL2 4QE Slough
    Berkshire
    Amministratore
    Flint Meadow
    Hockley Lane Stoke Poges
    SL2 4QE Slough
    Berkshire
    EnglandBritish56324870005
    MALTBY, John Neil
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    Amministratore
    Priory House
    Priory Close
    BR7 5LB Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish84264890001
    SANDERS, Colin George
    Tower Road
    Coleshill
    HP7 0LB Amersham
    Orchard House
    Bucks
    United Kingdom
    Amministratore
    Tower Road
    Coleshill
    HP7 0LB Amersham
    Orchard House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritish131520530001
    SPARKS, Daniel
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Amministratore
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    British127187010001
    STOLZ, Jeff
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Amministratore
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    United KingdomBritish127186730001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A security agreement
    Creato il 23 nov 2007
    Consegnato il 07 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Goldham Sachs Credit Partners (Europe) LTD
    Transazioni
    • 07 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed and floating charge security document
    Creato il 01 ago 2007
    Consegnato il 17 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Part of first and second floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesex and fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital and book debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kensington Group PLC
    Transazioni
    • 17 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 lug 2006
    Consegnato il 01 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 01 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 apr 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    First supplemental mortgage
    Creato il 24 feb 2006
    Consegnato il 25 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h interest in part first floor west part first floor east and part second floor storage and part second floor keaton house widewater place moorhall road harefield uxbridge middlesex,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kensington Group PLC
    Transazioni
    • 25 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 03 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 03 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating security document
    Creato il 16 giu 2004
    Consegnato il 22 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The l/h interest held by the chargor in the premises k/a (I) part first floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesex; (ii) part second floor of keaton house, widewater place, moorhall road, harefield, uxbridge, middlesx; fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kensington Group PLC
    Transazioni
    • 22 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MONEY PARTNERS HOLDINGS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    30 dic 2013Data di scioglimento
    24 set 2012Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Simon Wilson
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Praticante
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0