CARILLION HEATING SERVICES LIMITED
Panoramica
Nome della società | CARILLION HEATING SERVICES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04996458 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Crown House Birch Street WV1 4JX Wolverhampton United Kingdom |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
EAGA HEATING SERVICES LIMITED | 24 feb 2009 | 24 feb 2009 |
IGUANA SERVICES LIMITED | 16 dic 2003 | 16 dic 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Francis Tapp come amministratore in data 18 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alison Margaret Shepley come segretario in data 21 dic 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Francis Tapp il 01 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Carillion House 84 Salop Street Wolverhampton WV3 0SR a Crown House Birch Street Wolverhampton WV1 4JX in data 01 ott 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Carillion Energy Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 25 giu 2018 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Howson come amministratore in data 15 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 20 nov 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 11 set 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Hayward come amministratore in data 06 gen 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Zafar Iqbal Khan il 01 gen 2017 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Zafar Iqbal Khan come amministratore in data 31 ott 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard John Adam come amministratore in data 31 ott 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 16 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Hayward il 02 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alison Margaret Shepley il 17 mar 2015 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDD, Christopher | Segretario | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear | British | 69049410002 | ||||||
JUDD, Christopher | Segretario | 11 Lyndhurst Drive Low Fell NE9 6BB Gateshead Tyne & Wear | British | Solicitor | 69049410002 | |||||
LINTON, David Glyn | Segretario | 13 Bachelors Lane Chester CH3 5XD Cheshire | British | Solicitor | 96201780001 | |||||
SHEPLEY, Alison Margaret | Segretario | 7-12 Tavistock Street WC1H 9LT London Lynton House, 2nd Floor United Kingdom | 160692780001 | |||||||
JL NOMINEES TWO LIMITED | Segretario nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007220001 | |||||||
ADAM, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 67133560004 | ||||
BAILEY, John Roger | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear | United Kingdom | British | Director | 36401580001 | ||||
GUISE, Ashley Charles | Amministratore | 9 Kingfisher Beach Collingham LS22 5LX Wetherby West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 143094080001 | ||||
HAYWARD, Alan | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 154549030001 | ||||
HODGES, David | Amministratore | Laburnum House West Thirston NE65 9EF Morpeth Northumberland | British | Director | 103341630001 | |||||
HOWSON, Richard John | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | Executive Director | 147650310001 | ||||
JOHNSON, Joseph Andrew | Amministratore | Glenshotton West Thirston NE65 9QD Morpeth Northumberland | United Kingdom | British | Director | 69508510004 | ||||
KHAN, Zafar Iqbal | Amministratore | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | Group Finance Director | 195408780001 | ||||
MC MAHON, Michael | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear | United Kingdom | British | Director | 135269140001 | ||||
MCDONOUGH, John | Amministratore | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 West Midlands United Kingdom | Uk | British | Group Chief Executive | 74536340007 | ||||
RODGERS, Richard | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House Tyne And Wear | Northern Ireland | British | Director | 155728470001 | ||||
SPANN, Neil | Amministratore | Regent Farm Road Gosforth NE3 3AF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | Accountant | 154870250001 | ||||
TAPP, Richard Francis | Amministratore | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | England | British | Solicitor | 173852420001 | ||||
TURNBULL, Stephen Andrew | Amministratore | 3 Howden Bank Cottages Maiden Law DH7 0QP Lanchester County Durham | British | Accountant | 106874760001 | |||||
VARLEY, Paul Richard | Amministratore | City West Business Park Scotswood Road NE4 7DF Newcastle Upon Tyne Partnership House United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 137984880002 | ||||
WILLIAMS, Christopher Mark | Amministratore | 55 New Ridley Road NE43 7EY Stocksfield Northumberland | British | Director | 92461820001 | |||||
JL NOMINEES ONE LIMITED | Amministratore delegato nominato | 1 Saville Chambers 5 North Street NE1 8DF Newcastle Upon Tyne | 900007210001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di CARILLION HEATING SERVICES LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carillion Energy Services Limited | 06 apr 2016 | Birch Street WV1 4JX Wolverhampton Crown House United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
CARILLION HEATING SERVICES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 10 mar 2011 Consegnato il 15 mar 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 17 mar 2009 Consegnato il 20 mar 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0