LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED
Panoramica
Nome della società | LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04996908 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Indirizzo della sede legale | 100 Victoria Street SW1E 5JL London England |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
HERMES FREEPORT GP LIMITED | 16 dic 2003 | 16 dic 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ago 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione di Ls Outlets No 1 Gp Limited come persona con controllo significativo il 23 nov 2018 | 1 pagine | PSC07 | ||||||||||
Notifica di Land Securities Spv's Limited come persona con controllo significativo il 23 nov 2018 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 06 ago 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Louise Miller come amministratore in data 01 gen 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Elizabeth Miles come amministratore in data 01 gen 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2017 al 31 mar 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 ott 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 47 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Hermes Factory Outlets Gp Limited come persona con controllo significativo il 26 mag 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Avviso di cambio di nome" | 2 pagine | CONNOT | ||||||||||
Cessazione della carica di Hermes Secretariat Limited come segretario in data 15 mag 2017 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Paul Thomas Wray come amministratore in data 15 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Christopher Raymond Andrew Darroch come amministratore in data 15 mag 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Ls Director Limited come amministratore in data 15 mag 2017 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Nomina di Louise Miller come amministratore in data 15 mag 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Ls Company Secretaries Limited come segretario in data 15 mag 2017 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Nomina di Land Securities Management Services Limited come amministratore in data 15 mag 2017 | 2 pagine | AP02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Hermes Administration Services Ltd Lloyds Chambers 1 Portsoken Street London E1 8HZ a 100 Victoria Street London SW1E 5JL in data 18 mag 2017 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LS COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 159674790001 | ||||||||||
MILES, Elizabeth | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 235498150001 | ||||||||
LAND SECURITIES MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 74974580001 | ||||||||||
LS DIRECTOR LIMITED | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom |
| 133814600001 | ||||||||||
HERMES SECRETARIAT LIMITED | Segretario | 1 Portsoken Street E1 8HZ London Lloyds Chambers United Kingdom |
| 93700910001 | ||||||||||
SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
AGNEW, Julian Michael | Amministratore | Cavendish Square W1A 2NF London 33 | England | British | Investment Manager | 151724030002 | ||||||||
DARROCH, Christopher Raymond Andrew | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Scotland | British | Chartered Surveyor | 81530460007 | ||||||||
DEWHIRST, Andrew David | Amministratore | 59 Old Park View EN2 7EQ Enfield Middlesex | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 29539910003 | ||||||||
EVANS, Alasdair David | Amministratore | 8 Copsem Lane KT10 9EU Esher Treaton Mill Surrey | United Kingdom | British | Director | 130019430001 | ||||||||
MARTIN, Andrew John, Mr. | Amministratore | Hazelryst Rystwood Road RH18 5LX Forest Row East Sussex | England | British | Chartered Surveyor | 3565840001 | ||||||||
MILLER, Louise | Amministratore | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 199935770001 | ||||||||
MOUSLEY, Emily Ann | Amministratore | Flat C, 1 Cranley Gardens, Muswell Hill N10 3AA London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 155262770001 | ||||||||
TILL, Paul Richard | Amministratore | Cavendish Square W1A 2NF London 33 United Kingdom | United Kingdom | British | Asset Manager | 69536070004 | ||||||||
WRAY, Paul Thomas | Amministratore | 15 Coulters Close Grove Green ME14 5SU Maidstone Kent | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 154681480001 | ||||||||
INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Securities Spv's Limited | 23 nov 2018 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Ls Outlets No 1 Gp Limited | 06 apr 2016 | Victoria Street SW1E 5JL London 100 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
LS BRAINTREE AND CASTLEFORD GP LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | Creato il 20 dic 2004 Consegnato il 30 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The f/h land k/a land lying to the north west of charter way braintree t/no's EX632902 and EX603735 the f/h land k/a freeport retails village tomahawk trail castleford t/n WYK708788 and WYK710458 the l/h land k/a freeport village amounderness way fleetwood t/n LA845311 all buildings fixtures fixed plant and machinery its goodwill uncalled capital its book and other debts by way of a first floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Charge over partnership interest | Creato il 12 mar 2004 Consegnato il 25 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito This document was updated against this company in error and should have gone against the record of hermes factory outlets gp limited 4996883 | |
Brevi particolari This document was updated against this company in error and should have gone against the record of hermes factory outlets gp limited 4996883. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fixed and floating security document | Creato il 12 mar 2004 Consegnato il 25 mar 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the security trustee, as agent for the lenders or the security trustee and/or possfund custodian trustee limited (together "the lenders") under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Freeport village braintree braintree essex t/ns EX603735 and EX632902 freeport village fleetwood fleetwood lancashire t/n LA845311 freeport village castleford yorkshire t/ns WYK708788 and WYK710458. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0