INTERCITY GROUP LIMITED

INTERCITY GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàINTERCITY GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05007870
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di INTERCITY GROUP LIMITED?

    • Altri servizi di pulizia (81299) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova INTERCITY GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Ground Floor Suite River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Kent
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di INTERCITY GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    URBANDRIFT LIMITED06 gen 200406 gen 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di INTERCITY GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per INTERCITY GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzioni

    Xfer of shares 01/03/2018
    RES13

    Dichiarazione di conformità presentata il 03 gen 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 gen 2017 con aggiornamenti

    8 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 15 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 12 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mar 2016

    Stato del capitale al 09 mar 2016

    • Capitale: GBP 522,653
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come segretario in data 28 set 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Jonathan Stephen Levine come amministratore in data 28 set 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Ian Saunders come amministratore in data 28 set 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Saunders come segretario in data 28 set 2015

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Simon Kenneth Giles come amministratore in data 09 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Scott Dudley come amministratore in data 12 feb 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 gen 2015

    Stato del capitale al 19 gen 2015

    • Capitale: GBP 522,653
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 feb 2014

    Stato del capitale al 25 feb 2014

    • Capitale: GBP 522,653
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    7 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * Aeroworks Adair Street Manchester M1 2NQ* in data 23 ago 2013

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di INTERCITY GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    201342820001
    GILES, Simon Kenneth
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish196768780001
    LEVINE, Jonathan Stephen
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    EnglandBritish19162600001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    British88908400002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Segretario
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    SAUNDERS, Mark
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Segretario
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    167235170001
    SCOBIE, James Martin
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    Segretario
    Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    1
    Kent
    England
    149533800001
    STRATFORD, Frederick
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Segretario
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    162163700001
    DWF SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    Segretario
    C/O Dwf Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3AA Manchester
    98868640001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BOYLE, Eugene Daniel
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    Amministratore
    Teach Ban
    Parkside Drive
    PR6 7PL Whittle Le Woods Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish86492920001
    BRADFORD, Richard James
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    United KingdomBritish72452740004
    CLEAVER, Simon Christopher
    42 Dunraven Road
    West Kirby
    CH48 4DU Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    42 Dunraven Road
    West Kirby
    CH48 4DU Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritish101689040001
    DOWE, Stephen William
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    10 Breary Lane East
    Bramhope
    LS16 9BJ Leeds
    West Yorkshire
    United KingdomBritish88908400002
    DUDLEY, Scott
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish166551090001
    HARDY-WILSON, Nigel Andrew
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    EnglandBritish149590930001
    HOWROYD, David Rowan
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    Amministratore
    Bay Tree House
    East Street
    TN20 6TY Mayfield
    East Sussex
    British72333480002
    MCGIVERN, James Patrick
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    Amministratore
    17 Acre Lane
    Heswall
    CH60 1UN Wirral
    Merseyside
    British120346770001
    PICKUP, James
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    Amministratore
    Crooklands Farm Goosnargh Lane
    Goosnargh
    PR3 2JU Preston
    Lancashire
    British35926750001
    SALISBURY, Keith William
    Dingle House The Hampsons
    Off Belmont Road
    BL7 9QR Bolton
    Lancashire
    Amministratore
    Dingle House The Hampsons
    Off Belmont Road
    BL7 9QR Bolton
    Lancashire
    EnglandBritish100442000001
    SAUNDERS, Mark Ian
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    Amministratore
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    England
    EnglandBritish139588670003
    SCOBIE, James Martin
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    Amministratore
    1 Eastcote
    BR6 0AU Orpington
    Kent
    United KingdomBritish73982880001
    STRATFORD, Frederick Anthony
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    Amministratore
    Adair Street
    M1 2NQ Manchester
    Aeroworks
    United KingdomBritish151871680001

    Chi sono le persone con controllo significativo di INTERCITY GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Roger Leonard Burdett
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Simon Giles
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Mr Jonathan Stephen Levine
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Mr David Mundell
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    06 apr 2016
    River House
    Maidstone Road
    DA14 5RH Sidcup
    Ground Floor Suite
    Kent
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    INTERCITY GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage of life policy
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 18 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Full title guarantee together with all money and bonuses. All options and rights policy no. LO192155203 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 18 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 05 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sovereign Capital Partners LLP
    Transazioni
    • 05 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed & floating charge
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 ott 2008
    Consegnato il 04 nov 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 04 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 13 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 20 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Northwest Business Investment Scheme
    Transazioni
    • 20 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 11 lug 2007
    Consegnato il 17 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 17 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 mag 2006
    Consegnato il 25 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 12 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The policies being policy number 14/7602826-9 and all other monies due thereafter. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 20 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy being- insurer: halifax life, policy no: ASSH034011, life or lives assured: eugene boyle and stephen william dowe, sum assured: £667,000 payable on first death, term of cover: 5 years and commencement date: 18TH november 2005 and all monies, bonuses, profits, additions and benefits.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 08 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of keyman life policies
    Creato il 30 nov 2005
    Consegnato il 08 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Assigns the policies and all monies which shall become payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Assignment of life policy
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 22 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The life policy and all sums assured by it and all bonuses and benefits which may arise under it. The company's whole right title and interest present and future in the policy being insurer halifax life limited policy no. ASSH021538 lives assured eugene boyle and stephen dowe sum assured death benefit of £326,000.00 per person. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 22 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Fixed and floating charge
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 24 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 24 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 16 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 16 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0