LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05017356 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| LLOYDS TSB MARITIME LEASING (NO.17) LIMITED | 16 gen 2004 | 16 gen 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 10 pagine | LIQ13 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 dic 2022 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 17 dic 2021 | 9 pagine | LIQ03 | ||||||||||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pagine | AD03 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 25 Gresham Street London EC2V 7HN a 1 More London Place London SE1 2AF in data 23 dic 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alyson Elizabeth Mulholland come segretario in data 08 dic 2020 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Colin Graham Dowsett come amministratore in data 01 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Gerard Ashley Fox come amministratore in data 01 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2019 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2018 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Alyson Elizabeth Mulholland il 04 mar 2019 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 16 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Laura Frances Dorey il 04 gen 2019 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Ms Laura Frances Dorey come amministratore in data 28 giu 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew John Kemp come amministratore in data 28 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOREY, Laura Frances Christabel | Amministratore | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 230255280001 | |||||
| JOHNSON, Michelle Antoinette Angela | Segretario | Floor East Tower House Charterhall Drive CH88 3AN Chester 1st England England | 179046840001 | |||||||
| MULHOLLAND, Alyson Elizabeth | Segretario | Chester Business Park CH4 9FB Chester Cawley House United Kingdom | 241424340001 | |||||||
| SLATTERY, Sharon Noelle, Mrs. | Segretario | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Irish | 45487120004 | ||||||
| BASING, Anthony Mark | Amministratore | 36 Selwyn Crescent AL10 9NN Hatfield Hertfordshire | British | 99221710001 | ||||||
| COOKE, Timothy John | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | England | British | 120834610001 | |||||
| CUMMING, Andrew John | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 46297770002 | |||||
| DOWSETT, Colin Graham | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | England | British | 152332230001 | |||||
| FOAD, Allan Robert | Amministratore | 19 Dukes Orchard DA5 2DU Bexley Kent | British | 40761160001 | ||||||
| FOX, Gerard Ashley | Amministratore | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 179100520001 | |||||
| GLEDHILL, Simon Christopher | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 152766650002 | |||||
| GRANT, Mark Andrew | Amministratore | Silverdale Avenue KT12 1EL Walton-On-Thames 177 Surrey | United Kingdom | British | 236442470001 | |||||
| HERBERT, Jon Mark | Amministratore | Old Broad Street EC2N 1HZ London 33 England England | United Kingdom | British | 203539400001 | |||||
| HIGGINS, Peter | Amministratore | 2 Grange Close RH1 4LW Bletchingley Surrey | England | British | 107984310001 | |||||
| ISAACS, Robin Alexander | Amministratore | Gresham Street EC2V 7AE London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 115548350001 | |||||
| JOSEPH, Michael William | Amministratore | The Hermitage St Leonards HP23 6NW Tring Hertfordshire | England | British | 44954410002 | |||||
| KEMP, Andrew John | Amministratore | Canons House Canons Way BS1 5LL Bristol Ground Floor United Kingdom | England | British | 222042280001 | |||||
| MILES, Peter Bernard | Amministratore | Brentwood House Winchester Road GU32 1JS West Meon Hampshire | British | 41327480001 | ||||||
| PELLY, Richard Fowler | Amministratore | 126 Dora Road Wimbledon SW19 7HJ London | England | British | 99868440002 | |||||
| TATE, George Truett | Amministratore | Gresham Street EC2V 7HN London 25 | England | American | 99804980001 | |||||
| VOWLES, Anthony Brian | Amministratore | Hopgardens Hopgarden Lane TN13 1PX Sevenoaks Kent | British | 75134410001 | ||||||
| WILLIAMS, Richard Owen | Amministratore | London Wall EC2Y 5AJ London 125 United Kingdom | England | British | 164554190001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Bank Leasing Limited | 06 apr 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A lessor proceeds account charge | Creato il 30 nov 2009 Consegnato il 04 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company's rights title and interest present and future in and to an interest bearing sterling account see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A deed of covenant | Creato il 30 nov 2009 Consegnato il 04 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The company's right title and interest present and future in and to the bahamas registered ship M.V. "grace barleria" with imo number 9315719 and official number 8001337 see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A first priority bahamas ship mortgage | Creato il 30 nov 2009 Consegnato il 03 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The bahamas registered ship m v grace barleria with imo number 9315719 and official number 8001337 and in her equipment and appurtenances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
LLOYDS BANK MARITIME LEASING (NO. 17) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0