SG LEASING (RUBY) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SG LEASING (RUBY) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05038975 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SG LEASING (RUBY) LIMITED?
- Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | One Bank Street Canary Wharf E14 4SG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| RBSSAF (22) LIMITED | 09 feb 2004 | 09 feb 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||
Cessazione della carica di Lindsay Ginnette Sides come amministratore in data 12 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Lethbridge Fowler come amministratore in data 12 ott 2023 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 050389750003 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 050389750004 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2022 | 9 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021 | 9 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020 | 16 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 10 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Neill Charles Proudfoot il 18 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Lethbridge Fowler il 18 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Catherine Marie Madeleine Balinska-Jundzill il 18 nov 2019 | 1 pagine | CH03 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Michael Dent il 18 nov 2019 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom a One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG in data 18 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 10 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Paul Shields come amministratore in data 20 mag 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALINSKA-JUNDZILL, Catherine Marie Madeleine | Segretario | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | 216771450001 | |||||||||||
| DENT, Nicholas Michael | Amministratore | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | United Kingdom | British | 43922780002 | |||||||||
| PROUDFOOT, Neill Charles | Amministratore | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | United Kingdom | British | 155380760003 | |||||||||
| DOWN, Carolyn Jean | Segretario | 280 Bishopsgate EC2M 4RB London 4th Floor England | Other | 67499700004 | ||||||||||
| THOMAS, Marina Louise | Segretario | Richmond Lodge Rhinefield Road SO42 7SQ Brockenhurst Hampshire | British | 80901390001 | ||||||||||
| RBS SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Segretario | St Andrew Square EH2 1AF Edinburgh 24-25 Scotland |
| 169073830001 | ||||||||||
| CASTLEDINE, Trevor Vaughan | Amministratore | 22 Woodhayes Road Wimbledon SW19 4RF London | British | 98778780002 | ||||||||||
| CATERER, Sharon Jill | Amministratore | The Promonade GL50 1PX Cheltenham The Quadrangle Gloucestershire England | England | British | 15490360001 | |||||||||
| CHEESMAN, Philip Antony | Amministratore | Great Tower Street EC3P 3HX London 5-10 England | England | British | 157812490001 | |||||||||
| CLEMETT, Graham Colin | Amministratore | 15 Winchester Close KT10 8QH Esher Surrey | United Kingdom | British | 123744930001 | |||||||||
| COOK, Stuart Donald | Amministratore | Tower Hill EC3N 4SG London Sg House 41 United Kingdom | United Kingdom | British | 191477240004 | |||||||||
| DEVINE, Alan Sinclair | Amministratore | 42 Mirfield Road B91 1JD Solihull West Midlands | British | 96634670001 | ||||||||||
| FARNELL, Adrian Colin | Amministratore | Whitestrand Gadshill Road Charlton Kings GL53 8EF Cheltenham Gloucestershire | England | British | 43015720002 | |||||||||
| FOWLER, Stephen Lethbridge | Amministratore | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 135237620002 | |||||||||
| GEORGIOU, Andreas | Amministratore | Little Hallingbury Bishops Stortford CM22 7RJ Herts The Lodge, Goose Lane England | British | 88113470002 | ||||||||||
| LATTER, William Vaughan | Amministratore | Mernian Bushley GL20 6HX Tewkesbury Gloucestershire | British | 52914600004 | ||||||||||
| LOCKER, Graham Richard | Amministratore | Stratfirld Drive EN10 7NU Broxbourne 19 Hertfordshire | British | 132992690001 | ||||||||||
| PEARCE, Nigel | Amministratore | Willow Trees Hazelwood Lane CR5 3PF Chipstead Surrey | United Kingdom | British | 63084840002 | |||||||||
| SHIELDS, Paul, Mr. | Amministratore | Sg House 41 Tower Hill EC3N 4SG London C/O Group Legal United Kingdom | England | British | 244361960001 | |||||||||
| SIDES, Lindsay Ginnette | Amministratore | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 212141970001 | |||||||||
| SLATTERY, Domhnal | Amministratore | 16 Ailesbury Road Ballsbridge IRISH Dublin 4 Ireland | Republic Of Ireland | Irish | 154385180001 | |||||||||
| SULLIVAN, Paul Denzil John | Amministratore | Berberry Drive MK45 5ER Flitton 10 Bedfordshire England | England | British | 111421900001 | |||||||||
| TUBB, Philip Anthony | Amministratore | 15 Mardleybury Road SG3 6SG Datchworth Hertfordshire | British | 98115740001 | ||||||||||
| VARNAVIDES, Lambros | Amministratore | Cedars 24 Uphill Road Mill Hill NW7 4RB London | England | British | 33245340001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SG LEASING (RUBY) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale | 30 set 2016 | Boulevard Haussmann 75009 Paris 29 France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
SG LEASING (RUBY) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 13 ott 2016 Consegnato il 17 ott 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 30 set 2016 Consegnato il 17 ott 2016 | Soddisfatta integralmente | ||
Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standby security assignment (lng carrier hull no 1778) | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 12 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title interest and benefits in and to the put option agreement the novation agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standby proceeds account charge (lng carrier hull no 1778) | Creato il 31 mar 2005 Consegnato il 12 apr 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All monies standing to the credit of the standby proceeds account (interest bearing dollar account of the company with the chargee account number RBSPBS78) and any other account deemed to be the standby proceeds account. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0