CBRAIL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCBRAIL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05050256
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CBRAIL LIMITED?

    • Leasing finanziario (64910) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CBRAIL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CBRAIL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CBRAIL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CBRAIL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagine4.71

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Tower House Charterhall Drive Chester CH88 3AN United Kingdom a Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Level 7 Bishopsgate Exchange 155 Bishopsgate London EC2M 3YB a 1 More London Place London SE1 2AF in data 19 dic 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 28 nov 2014

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Nomina di Lloyds Secretaries Limited come segretario in data 13 nov 2014

    2 pagineAP04

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital19 feb 2014

    Stato del capitale al 19 feb 2014

    • Capitale: EUR 500,000
    • Capitale: GBP 1
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Gavin White come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Neil Dewar Lewis il 23 gen 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr Colin Graham Dowsett come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy Durham come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    17 pagineAA

    Nomina di Mr Neil Dewar Lewis come amministratore

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Gavin White il 07 mar 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 19 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    legacy

    6 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di CBRAIL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    LLOYDS SECRETARIES LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02791894
    73512200003
    DOWSETT, Colin Graham
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish152332230001
    LEWIS, Neil Dewar
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Old Burlington Street
    W1S 3AG London
    C/O Lw2
    United Kingdom
    EnglandBritish103229440001
    DOWNS, Steven George
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    Segretario
    Scarecrows
    66 Leas Road
    CR6 9LL Warlingham
    Surrey
    British16641880002
    GITTINS, Paul
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    Segretario
    House
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Tower
    United Kingdom
    British45660860003
    LODGE, Matthew Sebastian
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    Segretario
    Rose Cottage Dog Lane
    Stainland
    HX4 9QF Halifax
    West Yorkshire
    British32609030001
    WHITE, Gavin Raymond
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United Kingdom
    165229200001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritish96202910001
    DAVY, Philip Maturin
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    Amministratore
    Fair Meadow
    Broxmead Lane
    RH17 5JH Cuckfield
    West Sussex
    EnglandBritish96202910001
    DUNCAN, Timothy
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    Ellerslie House
    The Glade
    KT20 6LL Kingswood
    Surrey
    United KingdomBritish104005710001
    DURHAM, Timothy Sebastian
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    England
    England
    United KingdomBritish152682880001
    GOOSEN, Willem
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    Amministratore
    Vogelsangstrasse 6
    Grunwald
    82031
    Germany
    Dutch104881570002
    LEWIS, Neil Dewar
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    Amministratore
    15th Floor
    5 Aldermanbury Square
    EC2V 7HR London
    Babcock & Brown International Group
    EnglandBritish103229440001
    MARR, Graham Peter Wilson
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    Amministratore
    Mole Rise
    15 Harebell Hill
    KT11 2RS Cobham
    Surrey
    EnglandBritish69564800002
    MORE, Gordon Lennie Truman
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    Amministratore
    20 Dollarbeg Park
    FK14 7LJ Dollar
    Clackmannanshire
    United KingdomScottish111414890002
    MORRISSEY, John Michael
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    Amministratore
    66 Selborne Road
    Southgate
    N14 7DG London
    EnglandBritish94094650001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    British95498730001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Amministratore
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish125918020001
    WILSON, Edward Arthur
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    Amministratore
    Flat 3 28 Folgate Street
    E1 6BX London
    United KingdomBritish214718430001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    CBRAIL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 07 apr 2006
    Consegnato il 26 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge in and to all of the secured property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 29 mar 2006
    Consegnato il 06 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or the security trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to the shares and all stock shares warrents securities rights moneys and property (including the dividends interest or income thereon or wherefrom). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transazioni
    • 06 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A charge over shares
    Creato il 21 dic 2005
    Consegnato il 23 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cbrail (nordarz) limited to the bank or the chargee on any accountw hatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the shares and all stock shares warrants securities rights moneys or property (including dividends interest or income). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders
    Transazioni
    • 23 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 27 ott 2005
    Consegnato il 07 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from cbrail (ruhr-sieg) limited to the chargee or the bank on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights, title and interest in and to the shares (including the dividends). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited, as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transazioni
    • 07 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 13 gen 2005
    Consegnato il 28 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transazioni
    • 28 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A charge over shares
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 19 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured property being the shares and all stock, shares warrants, including the dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland Structured Asset Finance Limited as Security Trustee for and on Behalf of Thebank and Any Other Lenders from Time to Time
    Transazioni
    • 19 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    CBRAIL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 apr 2016Data di scioglimento
    28 nov 2014Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0