VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED

VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05050748
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    500 Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ALNERY NO.2416 LIMITED20 feb 200420 feb 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di William Thomas Castell come amministratore in data 09 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Roderick Gregor Mcneil come amministratore in data 09 mar 2020

    2 pagineAP01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Indirizzo della sede legale modificato da Media House Bartley Wood Business Park Hook Hampshire RG27 9UP a 500 Brook Drive Reading RG2 6UU in data 16 dic 2019

    1 pagineAD01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 23/10/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale al 31 ott 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 23 ott 2019

    • Capitale: GBP 6
    3 pagineSH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    13 pagineAA

    legacy

    88 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Nomina di Mr William Thomas Castell come amministratore in data 09 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Dominic Dunn come amministratore in data 09 set 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 050507480010 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 050507480008 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Segretario
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    151571360001
    HIFZI, Mine Ozkan
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish267964620001
    COWLISHAW, Paul Michael
    Corner Barn
    Chesterblade
    BA4 4QX Shepton Mallet
    Somerset
    Segretario
    Corner Barn
    Chesterblade
    BA4 4QX Shepton Mallet
    Somerset
    British98837060001
    GRAM, Peter Gerardus
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    Segretario
    9 Lambyn Croft
    Langshott
    RH6 9XU Horley
    Surrey
    British67245530001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Segretario nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Segretario
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002
    ALEXANDER, Thomas Simon
    The Old Rectory
    BS39 5AN Hinton Blewett
    Somerset
    Amministratore
    The Old Rectory
    BS39 5AN Hinton Blewett
    Somerset
    United KingdomBritish118149130001
    CASTELL, William Thomas
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    EnglandBritish96956740001
    GOW, Alan Mackenzie
    6 Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    Amministratore
    6 Wilkins Green Lane
    AL10 9RT Hatfield
    United KingdomBritish161497660001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish47785600002
    STEEL, Jonathan Douglas Hankin
    81 Kirkstall Road
    SW2 4HE London
    Amministratore
    81 Kirkstall Road
    SW2 4HE London
    British68837480001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish164134250001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United KingdomBritish140137570002
    ALNERY INCORPORATIONS NO 1 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002920001
    ALNERY INCORPORATIONS NO 2 LIMITED
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    Amministratore delegato nominato
    9 Cheapside
    EC2V 6AD London
    900002910001
    VIRGIN MEDIA DIRECTORS LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107430002
    VIRGIN MEDIA SECRETARIES LIMITED
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    Amministratore
    160 Great Portland Street
    W1W 5QA London
    101107380002

    Chi sono le persone con controllo significativo di VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    England
    06 apr 2016
    Bartley Wood Business Park
    Bartley Way
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3741555
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    VIRGIN MOBILE GROUP (UK) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 lug 2019
    Consegnato il 10 lug 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 mag 2019
    Consegnato il 24 mag 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 24 mag 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 mar 2017
    Consegnato il 23 mar 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 23 mar 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 01 feb 2017
    Consegnato il 07 feb 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 07 feb 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 apr 2016
    Consegnato il 27 apr 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch as Security Trustee
    Transazioni
    • 27 apr 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2015
    Consegnato il 06 mag 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 06 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 mar 2015
    Consegnato il 01 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 01 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 gen 2015
    Consegnato il 06 feb 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transazioni
    • 06 feb 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 04 apr 2014
    Consegnato il 10 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 10 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 mar 2014
    Consegnato il 02 apr 2014
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 02 apr 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 giu 2013
    Consegnato il 14 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag,London Branch
    Transazioni
    • 14 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Confirmation deed
    Creato il 03 mar 2011
    Consegnato il 15 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the security trustee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the issuance of the new notes, the new guarantees and the new indenture and the transactions contemplated thereby and hereby confirms all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of liens under and subject to the terms of the liens, the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 15 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite debenture
    Creato il 29 giu 2010
    Consegnato il 08 lug 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and all monies due or to become due from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 08 lug 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite debenture
    Creato il 19 gen 2010
    Consegnato il 22 gen 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) and from all or any of the obligors to the hedge counterparties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 lug 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A composite debenture
    Creato il 18 set 2006
    Consegnato il 03 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, all monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) including from the borrowers to any finance party and all monies due or to become due from the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counterparties and from the obligors to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 03 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 02 lug 2004
    Consegnato il 16 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0