RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED

RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05059318
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    3360TH SINGLE MEMBER SHELF TRADING COMPANY LIMITED01 mar 200401 mar 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    9 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 lug 2013

    Stato del capitale al 02 lug 2013

    • Capitale: GBP 2,690
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Emmett Mcevoy il 25 giu 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew John Mcdonald il 25 giu 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jim Hepburn il 25 giu 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    9 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Antony Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Emmett Mcevoy come amministratore

    2 pagineAP01

    legacy

    21 pagineMG01

    Risoluzioni

    Resolutions
    34 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Avviso di rimozione della restrizione sullo statuto sociale

    2 pagineCC02

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Nomina di Mr Andrew Mcdonald come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Suzanne Wise come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Jim Hepburn come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Antony David Smith come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Peeler come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Segretario
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    HEPBURN, Jim
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ScotlandScottish162125080001
    MCDONALD, Andrew John
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrish168590540001
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    Segretario
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    Segretario
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    SISEC LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Segretario nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024810001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    Amministratore
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    Amministratore
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    Amministratore
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    LEACH, Paul Alan
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Station Road
    Bletchingdon
    OX5 3DE Kidlington
    8
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish136797430001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    OAKLEY, Christopher Richard
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    26 Long Park
    Chesham Bois
    HP6 5LA Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish124625030001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    Amministratore
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002
    PEELER, Andrew Michael
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish87359710001
    SCHOFIELD, Robert John
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    Amministratore
    32 Thames Edge Court
    Clarence Street
    TW18 4SP Staines
    Middlesex
    United KingdomBritish80018490002
    SCHURCH, Michael John
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    Amministratore
    1 Aldersey Road
    GU1 2ER Guildford
    Surrey
    United KingdomBritish42065200002
    SMITH, Antony David
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Centrium Business Park
    Griffiths Ways
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish147725160001
    THOMAS, Paul
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Gladwyn House 5 Victoria Crescent
    Sherwood
    NG5 4DA Nottingham
    Nottinghamshire
    British29218800002
    WISE, Suzanne Elizabeth
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    Amministratore
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish136781050001
    LOVITING LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Amministratore delegato nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024790001
    SERJEANTS' INN NOMINEES LIMITED
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    Amministratore delegato nominato
    21 Holborn Viaduct
    EC1A 2DY London
    900024800001

    RHM PROPERTY HOLDING COMPANY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An english law security agreement
    Creato il 30 mar 2012
    Consegnato il 04 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all rights in respect of key brand ipr including any interest by way of licence in any such key brand ipr by way of a first floating charge all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Agent and Trustee for the Expanded Secured Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 27 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any expanded secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge against all assets not at any time otherwise effectively mortgage charged or assigned under the deed see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 12 gen 2009
    Consegnato il 22 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all its assets not at any time otherwise effectively mortgaged, charged or assigned see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Group debenture
    Creato il 28 feb 2008
    Consegnato il 10 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge over the undertaking and all property and assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 10 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 feb 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A supplemental deed to a group debenture
    Creato il 13 apr 2007
    Consegnato il 24 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its property, assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future, including any of its property and assets situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mag 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession
    Creato il 14 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the lenders (or any of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares; all buildings and fixtures; all plant, machinery; its goodwill and uncalled capital;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jp Morgan Chase Bank, N.A. (As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of accession
    Creato il 14 mar 2005
    Consegnato il 24 mar 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the lenders (or any of them) to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares; all buildings and fixtures; all plant, machinery; its goodwill and uncalled capital;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jp Morgan Chase Bank, N.A. (As Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders)
    Transazioni
    • 24 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 apr 2004
    Consegnato il 06 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor or the parent to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Golden west foods bakery 3 cherry trees lane hemel hempstead hertfordshire f/h t/no HD310833 and HD392928; golden west foods bakery land on the north of hareshill road heywood, rochdale greater manchester f/h t/no GM561433; golden west foods manufacturing plant land on the north side of steel road willowbrook north corby northamptonshire f/h t/no NN127397 for details of further properties charged please refer to form 395; all buildings and fixtures; all plant, machinery; its goodwill and uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 06 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0