GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED

GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàGUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05068857
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    • Strutture residenziali di assistenza infermieristica (87100) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor Asticus Building
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 apr 2016

    Stato del capitale al 05 apr 2016

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 20 lug 2015

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Sanne Group Pollen House 10/12 Cork Street London W1S 3NP a 2nd Floor Asticus Building 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 05 ago 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Nomina di Jonathan David Farkas come amministratore in data 27 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mathieu Streiff come amministratore in data 27 gen 2015

    1 pagineTM01

    legacy

    28 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT1

    legacy

    3 pagineGUARANTEE1

    Bilancio annuale redatto al 10 mar 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2014

    Stato del capitale al 08 apr 2014

    • Capitale: GBP 10
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 2Nd Floor Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP* in data 08 apr 2014

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Mathieu Streiff il 31 mar 2014

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 31 mar 2014

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O Sanne Group 1 Berkeley Street London United Kingdom W1J 8DJ* in data 07 apr 2014

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 mar 2014 al 31 dic 2013

    3 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    9 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Segretario
    Palmer Street
    SW1H 0AD London
    21
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    FARKAS, Jonathan David
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    2nd Floor Asticus Building
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    2nd Floor Asticus Building
    LuxembourgAmerican193539990001
    PRICE, Jennifer
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    Segretario
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    British51570420001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Segretario
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    British52338530002
    CORMACK, Derek George
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandIrish67400530015
    HILL, Peter Martin
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    EnglandBritish130983750001
    JEFFERY, Paul Anthony Keith
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish65609290003
    PRICE, Gareth
    27 Railway Crescent
    CV36 4GD Shipston On Stour
    Warwickshire
    Amministratore
    27 Railway Crescent
    CV36 4GD Shipston On Stour
    Warwickshire
    EnglandBritish62073810002
    PRICE, Jennifer
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish51570420001
    PRICE, Trevor
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    Amministratore
    Harrow House
    Lower High Street
    GL55 6DY Chipping Campden
    Gloucestershire
    EnglandBritish51570510001
    SANDHU, Shahid Hussain Khan, Dr
    81 Ingestre Road
    B28 9EQ Birmingham
    Amministratore
    81 Ingestre Road
    B28 9EQ Birmingham
    EnglandBritish57227020001
    SCHOFIELD, Nigel Bennett
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    Amministratore
    Bradbury House 830 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish148139420001
    STREIFF, Mathieu Bernard
    10/12 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    Amministratore
    10/12 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    England
    United StatesAmerican200529310001
    WHITE, Ian James
    Wetherden Road
    Haughley Haughley Green
    IP14 3RE Stowmarket
    Wetherden Cottage
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Wetherden Road
    Haughley Haughley Green
    IP14 3RE Stowmarket
    Wetherden Cottage
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish133383410003

    Chi sono le persone con controllo significativo di GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    06 apr 2016
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building, 2nd Floor
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleThe Companies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione04258255
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    GUILDCARE (CAMPDEN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 lug 2010
    Consegnato il 06 ago 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and to all or any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. For details of property charged please refer to form MG01.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ago 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deed of accession
    Creato il 20 nov 2007
    Consegnato il 29 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge all plant and machinery all rental and other income all derivative rights goodwill uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 29 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 set 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignment of building contract
    Creato il 04 ott 2006
    Consegnato il 06 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title benefit and interest in the assigned documents meaning the agreement and all collateral instruments arising there from and all claims rights payments and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 06 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal mortgage
    Creato il 14 giu 2006
    Consegnato il 20 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a the guild sheep street chiping campden gloucestershire t/no GR291645 and GR294117. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 20 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ott 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0