IGUK LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIGUK LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05069243
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IGUK LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova IGUK LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di IGUK LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ANSA HOLDINGS LIMITED16 lug 200416 lug 2004
    INHOCO 3061 LIMITED10 mar 200410 mar 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di IGUK LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per IGUK LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Nomina di Philip Raymond Emmerson come amministratore in data 07 nov 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Stuart Pace come amministratore in data 14 dic 2022

    1 pagineTM01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Modifica dei dettagli di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Rjp Secretaries Limited come segretario in data 25 gen 2023

    1 pagineTM02

    Nomina di Cossey Cosec Services Limited come segretario in data 25 gen 2023

    2 pagineAP04

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022

    1 pagineCH02

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 10 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    8 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 09 ago 2019

    2 paginePSC05

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL in data 12 ago 2019

    1 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di IGUK LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14344691
    302964180001
    EMMERSON, Philip Raymond
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish200785940067
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05687325
    149588400001
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Segretario
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    British29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Segretario
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    British139480580001
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    British108973030002
    PRILL, Robert David
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    Segretario
    Moorfield, Roe Green
    Worsley
    M28 2FL Manchester
    8
    United Kingdom
    British131613520001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02989995
    61999120002
    BARRETT, John
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish118475070001
    BLACOW, Nigel David
    9 Sunningdale Way
    CH64 0UY Neston
    Cheshire
    Amministratore
    9 Sunningdale Way
    CH64 0UY Neston
    Cheshire
    British118475170002
    DAVIS, Peter Nicholas
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    35 Chatsworth Road
    Eccles
    M30 9DZ Manchester
    Lancashire
    EnglandBritish29902470001
    DICKINSON, Louise
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    HOLEBROOK, David
    7 Penmoor Chase
    Hazel Grove
    SK7 5BT Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    7 Penmoor Chase
    Hazel Grove
    SK7 5BT Stockport
    Cheshire
    British55572450004
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    KEYWORTH, Stanley John
    18 Landsdowne Crescent
    WR14 2AW Malvern
    Worcestershire
    Amministratore
    18 Landsdowne Crescent
    WR14 2AW Malvern
    Worcestershire
    EnglandBritish75121880002
    LAWRENCE, Kenneth William
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    Amministratore
    4 The Headway
    KT17 1UJ Ewell
    Surrey
    United KingdomBritish40388380001
    LEE, Peter Francis
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Amministratore
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritish63238350002
    MARSH, Andrew Neil
    17 Kenmore Drive
    WA15 8QN Timperley
    Cheshire
    Amministratore
    17 Kenmore Drive
    WA15 8QN Timperley
    Cheshire
    United KingdomBritish127118640001
    MAUDE, Simon David
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    United KingdomBritish89719660003
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish108973030002
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    POLLARD, Niall Mackinlay
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    Amministratore
    Caxton Road
    Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    6 Fulwood Park
    Lancashire
    EnglandBritish176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish127928260002
    WATKINS, Steven James
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    Amministratore
    Roscownans
    Old Kea
    TR3 6AX Truro
    Cornwall
    British127928260001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IGUK LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    5th Floor
    United Kingdom
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06732498
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    IGUK LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 13 set 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Blackstar 2016 Limited
    Transazioni
    • 13 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 16 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 02 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Investor)
    Transazioni
    • 02 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 30 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 30 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2009
    Accession deed
    Creato il 30 giu 2005
    Consegnato il 06 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The payment of the secured liabilities,any f/h or l/h property,its interest in present and future licences,fixed charge all othe present and future fittings,plant,equipment,machinery,tools,vehicles,furniture and other tangible movable property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Banks PLC ("the Security Trustee")
    Transazioni
    • 06 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 14 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Forits Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 14 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage of assurance policy
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 14 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the policy or policies of assurance described in the schedule to form 395 together with all bonuses and other moneys benefits and advantages that may become payable or accrue thereunder and the full benefit of the policies and all the right title and interest. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Fortis Bank S.A./N.V.
    Transazioni
    • 14 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2004
    Consegnato il 02 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barrington House Nominees Limited (Customer B) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 02 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0