AXIOM SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AXIOM SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05072628 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AXIOM SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova AXIOM SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | The Minster Building 21 Mincing Lane EC3R 7AG London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AXIOM SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| INHOCO 4041 LIMITED | 15 mar 2004 | 15 mar 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AXIOM SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per AXIOM SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark William Keogh come amministratore in data 01 dic 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Chantel Garfield come amministratore in data 01 dic 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ivan John Keane come amministratore in data 31 lug 2020 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 15 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Axiom Holdings Limited come persona con controllo significativo il 11 apr 2018 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Charles Taylor Administration Services Limited il 11 apr 2018 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Standard House 12-13 Essex Street London WC2R 3AA a The Minster Building 21 Mincing Lane London EC3R 7AG in data 11 apr 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 15 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2015 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Mark William Keogh come amministratore in data 29 gen 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Stephen Card come amministratore in data 29 gen 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 15 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di AXIOM SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES TAYLOR ADMINISTRATION SERVICES LIMITED | Segretario | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London Minster House England |
| 157558200001 | ||||||||||
| GARFIELD, Chantel Athlene | Amministratore | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building United Kingdom | England | British | 277038300001 | |||||||||
| BIRD, Robert Arthur | Segretario | 14 Coulsdon Rise CR5 2SA Coulsdon Surrey | British | 23723280001 | ||||||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
| CARD, Stephen | Amministratore | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 149789570001 | |||||||||
| CHOPOURIAN, Arthur Giragos | Amministratore | Doone Cottage Church Walk Wilmington DA2 7EL Dartford Kent | United Kingdom | British | 166350280001 | |||||||||
| CLARKE, Peter Arthur | Amministratore | 103 Westcar Lane KT12 5ES Walton On Thames Surrey | United Kingdom | British | 30911760001 | |||||||||
| FITZSIMONS, George William | Amministratore | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 105693390001 | |||||||||
| GOSS, Peter David | Amministratore | 10 The Spinney HA7 4QJ Stanmore Middlesex | England | British | 373060003 | |||||||||
| GREENSLADE, Peter Donald | Amministratore | Woodedge Cottage Bolney Road RG9 3NT Shiplake Oxfordshire | British | 106794910001 | ||||||||||
| JENNINGS, Thomas David | Amministratore | Commonwood Cottage Common Wood WD4 9BA Kings Langley Hertfordshire | Uk | British | 47666540004 | |||||||||
| KEANE, Ivan John | Amministratore | House 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard England | England | British | 65092840002 | |||||||||
| KEOGH, Mark William | Amministratore | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | England | Irish | 62140690001 | |||||||||
| OLIVER, Clive Stuart | Amministratore | 12-13 Essex Street WC2R 3AA London Standard House | United Kingdom | British | 139678150001 | |||||||||
| PEACHEY, Michael Edwin | Amministratore | 31 Cassel Avenue Branksome Park BH13 6JD Poole Sea Whispers Dorset | England | British | 141493130001 | |||||||||
| POWELL, John Francis | Amministratore | The Coppice Hook End Road Hook End CM15 0HB Brentwood Essex | British | 37106140001 | ||||||||||
| RAYMENT, Keith Robertson | Amministratore | 195 Pettits Lane RM1 4DX Romford Essex | British | 103924470001 | ||||||||||
| RIDDELL, Timothy Roger | Amministratore | 3 The Hollies DA3 7HU New Barn Kent | United Kingdom | British | 25980890002 | |||||||||
| TOWERS, Keith | Amministratore | Harestone Lane CR3 6AL Caterham 65 Surrey | England | British | 51876030005 | |||||||||
| WOODING, Vincent Paul | Amministratore | The Cottage Hillwood Close Hutton CM13 2PE Brentwood Essex | England | British | 99076660001 | |||||||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di AXIOM SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axiom Holdings Limited | 06 apr 2016 | 21 Mincing Lane EC3R 7AG London The Minster Building England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
AXIOM SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment of keyman insurance | Creato il 21 apr 2006 Consegnato il 28 apr 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All the assignors interests in and to the policy and the full benefit thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 02 lug 2004 Consegnato il 14 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0