KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED

KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05079880
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    10 Queen Street Place
    EC4R 1AG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    KIRKMERE LIMITED22 mar 200422 mar 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    10 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 02 lug 2018

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 19 dic 2017

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per David Charles Ebbrell il 17 lug 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 03 lug 2017

    LRESSP

    Cessazione della carica di Thierry Drinka come amministratore in data 23 mag 2017

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 22 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 apr 2016

    Stato del capitale al 05 apr 2016

    • Capitale: GBP 725,002
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per David Charles Ebbrell il 09 set 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    3 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800013, creata il 05 mag 2015

    59 pagineMR01

    Bilancio annuale redatto al 22 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 apr 2015

    Stato del capitale al 08 apr 2015

    • Capitale: GBP 725,002
    SH01

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800012, creata il 12 mar 2015

    64 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800011, creata il 12 mar 2015

    45 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800010, creata il 27 feb 2015

    48 pagineMR01

    Nomina di David Charles Ebbrell come amministratore in data 18 dic 2014

    2 pagineAP01

    legacy

    MG01

    Iscrizione di un'ipoteca

    MR01

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800008, creata il 22 dic 2014

    32 pagineMR01

    Iscrizione dell'ipoteca 050798800009, creata il 22 dic 2014

    32 pagineMR01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    14 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EBBRELL, David Charles
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    The Monument Building
    11 Monument Street
    EC3R 8AF London
    3rd Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish142799490002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    Segretario
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Segretario
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    British119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Segretario nominato
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BROOK, Robert William Middleton
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    Amministratore
    c/o Michelle Knott
    Dover Street
    W1S 4NA London
    28-29
    England
    United KingdomBritish149783170001
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Amministratore
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritish59050120004
    DRINKA, Thierry
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    FranceFrench192167590001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Amministratore
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritish71043680001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Amministratore
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritish110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    22 mar 2017La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 05 mag 2015
    Consegnato il 14 mag 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 mar 2015
    Consegnato il 24 mar 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited
    Transazioni
    • 24 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 mar 2015
    Consegnato il 24 mar 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 24 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2015
    Consegnato il 17 mar 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (The Pledgee)
    Transazioni
    • 17 mar 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2014
    Consegnato il 31 dic 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Managment Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 31 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 22 dic 2014
    Consegnato il 31 dic 2014
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited (The Security Agent)
    Transazioni
    • 31 dic 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Insurance receivables security agreement
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 29 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its rights under any contract of insurance and all monies paid under or in respect of all such contracts of insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 17 dic 2010
    Consegnato il 29 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 30 dic 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A charge over hedge documents
    Creato il 08 feb 2007
    Consegnato il 23 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all right title and interest from time to time in and to the hedge documents to which it is a party and all proceeds paid or payable thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 ott 2006
    Consegnato il 10 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from an obligor or by some other person of each obligor to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 10 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Aggrement and deed of creation of a first ranking right of mortgage
    Creato il 21 mag 2004
    Consegnato il 27 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtor, any of the guarantors or any of the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The plot of land with the buildings erected on it k/a 8171 mc vaassen runnenbergweg 12 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3358, the plot of land with the buildings on it k/a 8171 mb vaassen talhoutweg 2 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3533 and the part plot of land with the buildings erected on it k/a 8171 mc vaassen runnenbergweg 10 registered with the arnhem land registry as the municipality of vaassen section h number 3148. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed) (the Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 apr 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 21 apr 2004
    Consegnato il 11 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A floating charge over the assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties Under the Security Trust Deed (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 11 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 ott 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    KENMORE CAPITAL VAASSEN 1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 lug 2017Inizio della liquidazione
    25 apr 2019Data prevista di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Gardiner
    3 Castle Court Carnegie Campus
    KY11 8PB Dunfermline
    Praticante
    3 Castle Court Carnegie Campus
    KY11 8PB Dunfermline

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0