PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05081105
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONE ONE ONE LIMITED15 dic 200415 dic 2004
    PROTECTAGROUP LIMITED03 nov 200403 nov 2004
    ONE ONE ONE LIMITED23 mar 200423 mar 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2021

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Dean Clarke come segretario in data 22 feb 2022

    1 pagineTM02

    Nomina di Ardonagh Corporate Secretary Limited come segretario in data 22 feb 2022

    2 pagineAP04

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    22 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 16 dic 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium of £1628000 be reduced to nil - credited to retained reserves 01/12/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    4 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Minster Court London EC3R 7AA United Kingdom a 2 Minster Court Mincing Lane London EC3R 7PD in data 14 lug 2020

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Protectagroup Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 14 lug 2020

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Protectagroup Acquisitions Limited come persona con controllo significativo il 30 lug 2019

    2 paginePSC05

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Antonios Erotocritou come amministratore in data 01 ago 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Ms Diane Cougill come amministratore in data 01 ago 2019

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Tower Gate House Eclipse Park Sittingbourne Road Maidstone Kent ME14 3EN a 1 Minster Court London EC3R 7AA in data 30 lug 2019

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 050811050009 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ARDONAGH CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione03702575
    288842300001
    COUGILL, Diane
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Finance Officer158614590002
    ROSS, David Christopher
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    EnglandIrishDirector222326970001
    BROWN, Ian William
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    Segretario
    36 Beech Wood Drive
    Tonyrefail
    CF39 8JE Rhondda Cynon Taff
    Mid Glamorgan
    BritishDirector262382040001
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    British117669700002
    CLARKE, Dean
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    Segretario
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    253939990001
    GOURIET, Geoffrey Costerton
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    249087180001
    GREGORY, Jacqueline Anne
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    221972880001
    KIRKNESS, Barrie
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    Segretario
    76 Glan Y Ffordd
    CF15 7SL Taffs Well
    South Glamorgan
    British103733180001
    OWENS, Jennifer
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Segretario
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    183326340001
    RAGAN, Sharon Marie
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Segretario
    Old Tregyrnog Farmhouse
    St Brides Super Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    BritishInsurance Broker67745500003
    KTS SECRETARIES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Segretario
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474590001
    BARR, Graham Maxwell
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector125097020001
    BRICE, Ian Charles
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    Amministratore
    Sycamore Cottage
    Bonvilston
    CF5 6TR Cardiff
    South Glamorgan
    BritishChairman63706880001
    BROWN, Ian William
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishCompliance Director262382040001
    BROWN, Roger Michael
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    Amministratore
    Staceys Street
    ME14 1ST Maidstone
    2 County Gate
    Kent
    EnglandBritishCompany Director134140540001
    BRUCE, David James
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector171398800001
    CHARD, Michael Francis
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    Amministratore
    23 Knightsbridge Court
    CH1 1QG Chester
    UkBritishChairman45725420009
    CLARK, Samuel Thomas Budgen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector149939610001
    EGAN, Scott
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector170703910001
    EROTOCRITOU, Antonios
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Minster Court
    EC3R 7AA London
    1
    United Kingdom
    United KingdomCypriotDeputy Cfo167795710001
    EVANS, Ieuan Cennydd
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Ysgubor Goch
    Llandough
    CF71 7LR Cowbridge
    Vale Of Glamorgan
    WalesBritishDirector66329000004
    HAGGETT, Linda
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    Amministratore
    Graig Y Mynydd
    CF39 8FD Thomastown
    51
    Tonyrefail
    United KingdomWelshInsurance Broker137893590001
    HODGES, Mark Steven
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    United KingdomBritishDirector58444370003
    JOHNSON, Timothy David
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    Amministratore
    The Green
    Westerham
    TN16 1AS Kent
    Nursery Cottage 3a
    EnglandBritishCompany Director129538180001
    LYONS, Alastair David
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishExecutive Chairman193700540001
    MUGGE, Mark Stephen
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    EnglandBritishDirector162920630005
    PARK, Bryan
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector113694470002
    POWELL, Kenneth John
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    WalesBritishDirector27317930001
    RAGAN, Paul Robert
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    Amministratore
    Tregyrnog Farmhouse
    St. Brides-Super-Ely
    CF5 6EZ Cardiff
    Vale Of Glamorgan
    United KingdomBritishManaging Director60263070005
    REA, Michael Peter
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    Amministratore
    Gate House
    Eclipse Park Sittingbourne Road
    ME14 3EN Maidstone
    Tower
    Kent
    England
    EnglandBritishDirector147194830001
    RIDEWOOD, Gary Spencer
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    Amministratore
    Leigh Cottage
    Mount Road
    CF64 4DG Dinas Powys
    South Glamorgan
    WalesBritishFinance Director112745560001
    WIGLEY, William George
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    Amministratore
    46 Heol St Cattwg
    Pendoylan
    CF71 7UG Cowbridge
    South Glamorgan
    WalesBritishDirector193333870002
    KTS NOMINEES LIMITED
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    Amministratore
    The Counting House
    Dunleavy Drive
    CF11 0SN Cardiff
    84474580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Protectagroup Acquisitions Limited
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Minster Court
    Mincing Lane
    EC3R 7PD London
    2
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House Cardiff
    Numero di registrazione06512090
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    PROTECTAGROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 apr 2015
    Consegnato il 22 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    By way of first legal mortgage all legal interest in trademark registration/application number 2413912 as listed in schedule 5 (intellectual property) of the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Bank of New York Mellon, London Branch
    Transazioni
    • 22 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 mag 2013
    Consegnato il 23 mag 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to clause 3.1(b)(vii) of the charge, the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property, including the following:. Trademark registration/application number 2413912.. pursuant to the charge, the company charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge.. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 29 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security accession deed
    Creato il 27 giu 2012
    Consegnato il 07 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 07 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 set 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 giu 2012
    Consegnato il 06 lug 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other debtor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Agent and Trustee for Itself and the Other Secured Parties (The "Security Agent")
    Transazioni
    • 06 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of accession
    Creato il 04 giu 2008
    Consegnato il 17 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 17 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 26 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 ott 2004
    Consegnato il 20 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Guarantee & debenture
    Creato il 06 ott 2004
    Consegnato il 21 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 01 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0