BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD

BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàBLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 05089367
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLACKPOOL AIRPORT HOLDINGS LIMITED11 giu 200411 giu 2004
    MEAUJO (661) LIMITED31 mar 200431 mar 2004

    Quali sono gli ultimi bilanci di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020

    3 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ England a Mark Rebbeck - the Square Sc Management Office 18 Town Square Sale M33 7WZ in data 27 ago 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    10 pagineAA

    Cessazione della carica di Michael James Brown come amministratore in data 01 lug 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2016

    Stato del capitale al 18 mag 2016

    • Capitale: GBP 783,654
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Wolverhampton Halfpenny Green Airport Stourbridge West Midlands DY7 5DY a C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ in data 28 gen 2016

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014

    8 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 050893670004 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Michael James Brown come amministratore in data 11 mag 2015

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 783,654
    SH01

    Chi sono gli amministratori di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MURPHY, Noel Ferris
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    England
    Segretario
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office
    England
    154493510001
    MURPHY, Noel Ferris
    152 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Amministratore
    152 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern IrelandBritish99726990001
    HORNER, Robin George
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    Segretario
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    British145344800001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Segretario
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    British143588500001
    PHILSEC LIMITED
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    Segretario nominato
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    900006520001
    ARMSTRONG, Adam James Moore
    35 Warren Road
    BT21 0PD Donaghadee
    County Down
    Amministratore
    35 Warren Road
    BT21 0PD Donaghadee
    County Down
    United KingdomBritish184077380001
    BROWN, Michael James
    c/o Diane Smith
    Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    The Square Shopping Centre
    Cheshire
    England
    Amministratore
    c/o Diane Smith
    Management Office
    18 Town Square
    M33 7WZ Sale
    The Square Shopping Centre
    Cheshire
    England
    Northern IrelandBritish174874620001
    HORNER, Robin George
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    Amministratore
    4 Manor Park, Killinchy Road
    Comber
    BT23 5FW Newtownards
    County Down
    United KingdomBritish145344800001
    KERSHAW, David Francis
    3 Houghton Close
    CW9 8NW Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    3 Houghton Close
    CW9 8NW Northwich
    Cheshire
    UkBritish85601560002
    RUSH, William
    140 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    140 Warren Road
    BT21 0PQ Donaghadee
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish99727010001
    SILK, Graham Hampson
    Old Well Cottage Broome Clent
    DY9 0EZ Stourbridge
    West Midlands
    Amministratore
    Old Well Cottage Broome Clent
    DY9 0EZ Stourbridge
    West Midlands
    EnglandBritish3954850001
    WHELAN, Paul Edward
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    Amministratore
    5 Longheadland
    WR9 0JB Ombersley
    Worcestershire
    EnglandBritish143588500001
    MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    Amministratore delegato nominato
    St Philips House
    St Philips Place
    B3 2PP Birmingham
    West Midlands
    900006510001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 mar 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 23 dic 2013
    Consegnato il 04 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 04 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over bank accounts
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 20 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The account having account number 90530506 by way of fixed and floating charge all rights benefits and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of assignment over deferred consideration
    Creato il 01 mar 2010
    Consegnato il 13 mar 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from mar properties limited and mar (argyle) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of a first floating charge all the rights, title and interest referred to and insofar as such charges or any parts or the parts of the same are ineffective as specific or fixed charges see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 13 mar 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 05 lug 2004
    Consegnato il 15 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio being all the shares in the share capital of blackpool airport business park limited and the related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0