BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD
Panoramica
| Nome della società | BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 05089367 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Indirizzo della sede legale | Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office 18 Town Square M33 7WZ Sale England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BLACKPOOL AIRPORT HOLDINGS LIMITED | 11 giu 2004 | 11 giu 2004 |
| MEAUJO (661) LIMITED | 31 mar 2004 | 31 mar 2004 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2020 | 3 pagine | AA | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ England a Mark Rebbeck - the Square Sc Management Office 18 Town Square Sale M33 7WZ in data 27 ago 2021 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael James Brown come amministratore in data 01 lug 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2015 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Wolverhampton Halfpenny Green Airport Stourbridge West Midlands DY7 5DY a C/O Diane Smith the Square Shopping Centre Management Office 18 Town Square Sale Cheshire M33 7WZ in data 28 gen 2016 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 050893670004 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael James Brown come amministratore in data 11 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 31 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MURPHY, Noel Ferris | Segretario | 18 Town Square M33 7WZ Sale Mark Rebbeck - The Square Sc Management Office England | 154493510001 | |||||||
| MURPHY, Noel Ferris | Amministratore | 152 Warren Road BT21 0PQ Donaghadee County Down | Northern Ireland | British | 99726990001 | |||||
| HORNER, Robin George | Segretario | 4 Manor Park, Killinchy Road Comber BT23 5FW Newtownards County Down | British | 145344800001 | ||||||
| WHELAN, Paul Edward | Segretario | 5 Longheadland WR9 0JB Ombersley Worcestershire | British | 143588500001 | ||||||
| PHILSEC LIMITED | Segretario nominato | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006520001 | |||||||
| ARMSTRONG, Adam James Moore | Amministratore | 35 Warren Road BT21 0PD Donaghadee County Down | United Kingdom | British | 184077380001 | |||||
| BROWN, Michael James | Amministratore | c/o Diane Smith Management Office 18 Town Square M33 7WZ Sale The Square Shopping Centre Cheshire England | Northern Ireland | British | 174874620001 | |||||
| HORNER, Robin George | Amministratore | 4 Manor Park, Killinchy Road Comber BT23 5FW Newtownards County Down | United Kingdom | British | 145344800001 | |||||
| KERSHAW, David Francis | Amministratore | 3 Houghton Close CW9 8NW Northwich Cheshire | Uk | British | 85601560002 | |||||
| RUSH, William | Amministratore | 140 Warren Road BT21 0PQ Donaghadee County Down Northern Ireland | Northern Ireland | British | 99727010001 | |||||
| SILK, Graham Hampson | Amministratore | Old Well Cottage Broome Clent DY9 0EZ Stourbridge West Midlands | England | British | 3954850001 | |||||
| WHELAN, Paul Edward | Amministratore | 5 Longheadland WR9 0JB Ombersley Worcestershire | England | British | 143588500001 | |||||
| MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED | Amministratore delegato nominato | St Philips House St Philips Place B3 2PP Birmingham West Midlands | 900006510001 |
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 31 mar 2017 | La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società. |
BLACKPOOL BUSINESS PARK HOLDINGS LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 dic 2013 Consegnato il 04 gen 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione None. Notification of addition to or amendment of charge. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge over bank accounts | Creato il 15 mar 2013 Consegnato il 20 mar 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The account having account number 90530506 by way of fixed and floating charge all rights benefits and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment over deferred consideration | Creato il 01 mar 2010 Consegnato il 13 mar 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from mar properties limited and mar (argyle) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of a first floating charge all the rights, title and interest referred to and insofar as such charges or any parts or the parts of the same are ineffective as specific or fixed charges see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over shares | Creato il 05 lug 2004 Consegnato il 15 lug 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The charged portfolio being all the shares in the share capital of blackpool airport business park limited and the related assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0